ACRE 870 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéACRE 870 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05105848
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ACRE 870 LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe ACRE 870 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ACRE 870 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ACRE 870 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ACRE 870 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2014

    3 pages4.68

    Cessation de la nomination de Matthew Dent en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    10 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew Michael Dent le 20 juin 2012

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 mai 2012

    État du capital au 23 mai 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Matthew Michael Dent le 05 juil. 2011

    2 pagesCH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Richard Cotton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    10 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    14 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Richard James Cotton en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Matthew Michael Dent en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    12 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ACRE 870 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HENRY, Margaret Mary
    50 Perrers Road
    W6 0EZ London
    Secrétaire
    50 Perrers Road
    W6 0EZ London
    Other60968970001
    PHILLIPS, David
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    Administrateur
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    United KingdomBritishInvestment Director65062400001
    LAWSON (LONDON) LIMITED
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Secrétaire désigné
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    900018120001
    COTTON, Richard James
    The Cressinghams
    KT18 5DJ Epsom
    8
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    The Cressinghams
    KT18 5DJ Epsom
    8
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishSurveyor82283740005
    DENT, Matthew Michael
    South Audley Street
    W1K 2QS London
    63a
    Administrateur
    South Audley Street
    W1K 2QS London
    63a
    United KingdomBritishCompany Director100940280006
    ACRE (CORPORATE DIRECTOR) LIMITED
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Administrateur désigné
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    900021510001

    ACRE 870 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 juil. 2006
    Livré le 10 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the borrower or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Regal house and the rugby tavern public house,london rd,twickenham (SGL235915); first fixed charge over all rights in any land,all rental income,insurance,chattels,plant machinery,etc; the goodwill of business and uncalled capital,book and other debts,shares,stocks,debentures,bonds,etc. All other rights licences consents and other documents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 10 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Shares charge
    Créé le 21 juil. 2006
    Livré le 10 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the borrower or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All shares,distributions,interest,other income,voting rights,other benefits,money or property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 10 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of accounts
    Créé le 29 juil. 2004
    Livré le 10 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the charged account and the balances standing to the credit of the charged account and the charged funds,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 juil. 2004
    Livré le 27 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company as partner of the regal GB partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 juil. 2004
    Livré le 27 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    ACRE 870 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 mars 2013Commencement of winding up
    28 oct. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0