WESTARK PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWESTARK PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05112202
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WESTARK PROPERTIES LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WESTARK PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    27 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WESTARK PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour WESTARK PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 04 août 2022

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jeremy David Cape le 22 nov. 2021

    3 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    17 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jeremy David Cape le 05 août 2021

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 26 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Statuts

    12 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Mr Jeremy David Cape en tant qu'administrateur le 25 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Nasir Pasha en tant qu'administrateur le 25 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Liam Cunningham en tant que directeur le 25 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mahmoud Raafat en tant que directeur le 25 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    21 pagesAA

    Modification des détails de Coroin Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 août 2019

    5 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de C/O Maybourne Hotel Group 41-43 Brook Street Mayfair London W1K 4HJ England à 27 Knightsbridge London SW1X 7LY le 01 août 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 26 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de WESTARK PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAPE, Jeremy David
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Administrateur
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarBritish,Argentine280421610001
    PASHA, Nasir
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Administrateur
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarBritish280348180001
    SOCKER, Marc Nathan
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Administrateur
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    United KingdomBritish253588970001
    DOWD, Thomas Patrick
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Secrétaire
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Irish93945640001
    EDWARDS, Sara Louise
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    Secrétaire
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    British108281650001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Secrétaire
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GIBBONS, Clive Anthony
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    Secrétaire
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    British74719200002
    WALKER, Carole
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Secrétaire
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    British138522860001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALDEN, Stephen Jude
    c/o Maybourne Hotel Group
    Vine Street
    W1J 0AH London
    1
    England
    Administrateur
    c/o Maybourne Hotel Group
    Vine Street
    W1J 0AH London
    1
    England
    United KingdomMaltese115411150008
    ALLEN, David Weston
    8 Merton Walk
    Mount Saint Annes
    6 Milltown
    Dublin
    Ireland
    Administrateur
    8 Merton Walk
    Mount Saint Annes
    6 Milltown
    Dublin
    Ireland
    Irish99989350001
    BAKHOS, Fady
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Administrateur
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    QatarFrench206171430001
    CUNNINGHAM, Liam
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Administrateur
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    IrelandIrish198259330001
    DONNELLY, Peter Joseph
    104 Avoca Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    104 Avoca Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish93945650001
    DOWD, Thomas Patrick
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    United KingdomIrish93945640001
    EDWARDS, Sara Louise
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    Administrateur
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    United KingdomBritish108281650001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Administrateur
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritish50060390001
    GIBBONS, Clive Anthony
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    Administrateur
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    EnglandBritish74719200002
    HENNEBRY, Mark Nicholas
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W15 3AR Mayfair
    London
    Administrateur
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W15 3AR Mayfair
    London
    IrelandIrish128404490001
    MCKENNA, Geraldine Maria Martina
    31 Clancarty Road
    SW6 3AH London
    Administrateur
    31 Clancarty Road
    SW6 3AH London
    United KingdomIrish93995420001
    RAAFAT, Mahmoud
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Administrateur
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarEgyptian271030610001
    REYNOLDS, Paul
    30 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    Administrateur
    30 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    EnglandBritish108281880001
    SEELINGER, Lisa Eleonora
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W15 3AR Mayfair
    London
    Administrateur
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W15 3AR Mayfair
    London
    United KingdomAmerican128749960002
    WALKER, Carole
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Administrateur
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    EnglandBritish138522860001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WESTARK PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Coroin Limited
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    06 avr. 2016
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleEngland & Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House, England & Wales
    Numéro d'enregistrement05091711
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WESTARK PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 janv. 2015
    Livré le 30 janv. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited as Common Security Trustee (As Trustee for Each of the Finance Parties)
    Transactions
    • 30 janv. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 déc. 2012
    Livré le 08 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each debtor to any common secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited
    Transactions
    • 08 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over a bank account
    Créé le 01 avr. 2011
    Livré le 12 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The account and the account balance. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transactions
    • 12 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 avr. 2011
    Livré le 12 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee and each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transactions
    • 12 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 mai 2008
    Livré le 19 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The “Security Trustee”)
    Transactions
    • 19 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 mai 2008
    Livré le 19 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The “Security Trustee”)
    Transactions
    • 19 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Account charge
    Créé le 29 juin 2006
    Livré le 19 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its present and future rights title interest and benefit whatsoever present and future in and to the interest reserve account and the interest reserve account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 19 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Account charge
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 13 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title interest and benefit in and to the interest reserve account and the interest reserve account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 13 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 11 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings and fixtures,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 11 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 14 mai 2004
    Livré le 03 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC in Its Capacity as Trustee for the Secured Parties (Thesecurity Trustee)
    Transactions
    • 03 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0