PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED

PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPIONEER INNS & TAVERNS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05117368
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED ?

    • Débits de boissons et bars (56302) / Hébergement et restauration

    Où se situe PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Jubilee House, Second Avenue
    Burton Upon Trent
    DE14 2WF Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KENNELPOST LIMITED04 mai 200404 mai 2004

    Quels sont les derniers comptes de PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au18 août 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 mars 2020

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2018

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 19 août 2017

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 20 août 2016

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Neil Robert Ceidrych Griffiths en tant que directeur le 30 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 22 août 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mai 2016

    État du capital au 31 mai 2016

    • Capital: GBP 250,100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mai 2015

    État du capital au 28 mai 2015

    • Capital: GBP 250,100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 23 août 2014

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Edward Michael Bashforth en tant qu'administrateur le 07 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Francesca Appleby en tant que secrétaire le 07 oct. 2014

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Claire Louise Harris en tant que secrétaire le 07 oct. 2014

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 17 août 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mai 2014

    État du capital au 07 mai 2014

    • Capital: GBP 250,100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Roger Whiteside en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Neil Robert Ceidruch Griffiths en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Helen Tyrrell en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191628520001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    CLARKE, Stephen Paul
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    Secrétaire
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    British83058420001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488690001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Secrétaire
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    British51167890002
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161694360001
    GRAVITAS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    Secrétaire
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    48725320001
    SDG SECRETARIES LIMITED
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    Secrétaire désigné
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    900028430001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    CLARKE, Stephen Paul
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    Administrateur
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    EnglandBritish83058420001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish55975990001
    KENNEDY, Samual Edward
    Beaulieu House
    Roman Road
    RH4 3ET Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Beaulieu House
    Roman Road
    RH4 3ET Dorking
    Surrey
    EnglandBritish149343140001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    RUTHERFORD, Colin
    4 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    4 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish39515100002
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Administrateur
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    United KingdomBritish51167890002
    THORLEY, Giles Alexander
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81928120002
    WHITESIDE, Roger Mark
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish128819260001
    WRIGHT, Nigel Bryant
    Stonewalls Farm Street
    Harbury
    CV33 9LS Leamington Spa
    Administrateur
    Stonewalls Farm Street
    Harbury
    CV33 9LS Leamington Spa
    British99388470001
    GRAVITAS NOMINEES LIMITED
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    Administrateur
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    78501810001
    SDG REGISTRARS LIMITED
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    Administrateur désigné
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    900028420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2902824
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    First ranking fixed and floating security document
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 18 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transactions
    • 18 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 déc. 2005
    Livré le 23 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Encore 22/26 commercial road southampton. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession
    Créé le 18 juin 2004
    Livré le 29 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all real property being anchor & horseshoes guildford, bowd sidmouth, charnwood coalville for further details of the properties charged please refer to the form 395 by way of first fixed charge all its present and future book debts bank accouts investments uncalled capital and goodwill by way of first floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Benefit of Thecreditors (The Security Trustee)
    Transactions
    • 29 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating security document
    Créé le 28 mars 2002
    Acquis le 08 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    L/H land known as "encore" 22/26 commercial road southampton. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 13 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PIONEER INNS & TAVERNS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 mars 2020Commencement of winding up
    20 juin 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0