CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED

CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société 05122855
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Third Floor, Priory Place
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Essex
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2023

    Quels sont les derniers dépôts pour CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2024 au 30 sept. 2024

    1 pagesAA01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023

    38 pagesAA

    Cessation de la nomination de Yvonne Kelly en tant que directeur le 10 mai 2023

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Rosemary Greenlees le 22 mai 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Colin Mark Allison le 22 mai 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Colin Mark Allison le 22 mai 2023

    1 pagesCH03

    Déclaration de confirmation établie le 07 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Mary Nagele le 15 mars 2023

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2022

    37 pagesAA

    Cessation de la nomination de David James Charles Anderson en tant que directeur le 18 oct. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Carol Ann Harvey-Barnes en tant que directeur le 12 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alexandra Edith Porter-Smith en tant que directeur le 12 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 07 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Third Floor Priory Place New London Road Chelmsford CM2 0PP England à Third Floor, Priory Place New London Road Chelmsford Essex CM2 0PP le 31 mars 2022

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Third Floor, Priory Place New London Road Chelmsford Essex CM2 0PP England à Third Floor Priory Place New London Road Chelmsford CM2 0PP le 31 mars 2022

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Marlborough House Victoria Road South Chelmsford Essex CM1 1LN England à Third Floor, Priory Place New London Road Chelmsford Essex CM2 0PP le 31 mars 2022

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Oliver Llywelyn Morris en tant que directeur le 08 mars 2022

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Mark Allison le 17 janv. 2022

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Colin Allison le 17 janv. 2022

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2021

    37 pagesAA

    Cessation de la nomination de Martin Barry Penny en tant que directeur le 28 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Allison en tant qu'administrateur le 23 mars 2021

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALLISON, Colin Mark
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Secrétaire
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    281931710002
    ALLISON, Colin Mark
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    ScotlandBritishDirector287083690002
    FARROW, Graeme Alan
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    WalesBritishArtistic & Creative Director251922300001
    GREENLEES, Rosemary
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    EnglandBritishExecutive Director126904310002
    HAWKINS, Clare Margaret
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    EnglandBritishAdministration Manager229564410001
    HYSLOP, Donald William
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    EnglandBritishArts Manager94195000002
    NAGELE, Mary
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Northern IrelandIrishCeo266856560002
    NIKOLAIDOU, Vithleem Paraskevi
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    EnglandGreekHead Of Organisational Development229567440001
    RITMAN, Catherine Ann
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    EnglandBritishCultural Educationalist258693100001
    YARDLEY, Fiona Elizabeth
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    EnglandBritishFinance Director277553720001
    ARROWSMITH, Keith James
    Victoria Road South
    CM1 1LN Chelmsford
    Marlborough House
    Essex
    England
    Secrétaire
    Victoria Road South
    CM1 1LN Chelmsford
    Marlborough House
    Essex
    England
    171776910001
    BOTHA, David
    Lafone House The Leathermarket
    Weston Street
    SE1 3HN London
    Greater London
    Secrétaire
    Lafone House The Leathermarket
    Weston Street
    SE1 3HN London
    Greater London
    161689480001
    CABRERA, Julian
    Alexandra Terrace
    EX4 6SY Exeter
    2
    Devon
    United Kingdom
    Secrétaire
    Alexandra Terrace
    EX4 6SY Exeter
    2
    Devon
    United Kingdom
    British126526570004
    PRICE, Nick
    Lafone House The Leathermarket
    Weston Street
    SE1 3HN London
    Greater London
    Secrétaire
    Lafone House The Leathermarket
    Weston Street
    SE1 3HN London
    Greater London
    156261920001
    HAL MANAGEMENT LIMITED
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    Secrétaire
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    2851030001
    ALPS, Tess Margaret
    The Lodge
    New Ground Road Aldbury
    HP23 5SF Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Lodge
    New Ground Road Aldbury
    HP23 5SF Tring
    Hertfordshire
    United KingdomUkCeo Think Box74961400001
    ANDERSON, David James Charles
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    WalesBritishDirector156439090003
    ANDERSON, David James Charles
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    England
    Administrateur
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    England
    WalesBritishCeo156439090003
    ARROWSMITH, Keith James
    Lafone House The Leathermarket
    Weston Street
    SE1 3HN London
    Greater London
    Administrateur
    Lafone House The Leathermarket
    Weston Street
    SE1 3HN London
    Greater London
    United KingdomBritishSolicitor73027870001
    CALLENDER, Catriona Jane Lindsay
    38c Batoum Gardens
    W6 7QD London
    Administrateur
    38c Batoum Gardens
    W6 7QD London
    BritishManaging Director77905710003
    CLARE, Roy Alexander George, Rear Admiral
    Mellwick
    Tollesbury
    CM9 8XP Maldon
    Essex
    Administrateur
    Mellwick
    Tollesbury
    CM9 8XP Maldon
    Essex
    EnglandBritishMuseum Director108581800001
    CLEEVE, Lucy Newman
    131 Kennington Park Road
    SE11 4JJ London
    Administrateur
    131 Kennington Park Road
    SE11 4JJ London
    EnglandBritishArt Dealer123394760001
    CLIPSON, Gillian
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    England
    Administrateur
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    England
    United KingdomBritishPrincipal And Chief Executive163904890001
    DERRY, Kim Bromley
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    Administrateur
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    EnglandBritishCeo205661800001
    GLAISTER, Jane Margaret
    Myddle House
    Hepley View
    WF4 4ES Flockton
    West Yorkshire
    Administrateur
    Myddle House
    Hepley View
    WF4 4ES Flockton
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector Leisure Services161319480001
    GREEN, Richard Iain Crafton
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    England
    Administrateur
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    England
    United KingdomBritishOperations Technical Director94054060001
    GREENLEES, Rosy Rosemary
    36 Warkworth Street
    CB1 1EG Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    36 Warkworth Street
    CB1 1EG Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishExecutive Director126904310001
    HALL, Anthony William, Lord
    The Bishop's House
    55 New Street
    RG9 2BP Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Bishop's House
    55 New Street
    RG9 2BP Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector16369790002
    HARVEY-BARNES, Carol Ann
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    EnglandBritishDrama Consultant / Lecturer111336120001
    ISHERWOOD, Judith
    The Cottage
    Llantrisant Road, Groesfaen
    CF72 8NS Pontyclun
    Administrateur
    The Cottage
    Llantrisant Road, Groesfaen
    CF72 8NS Pontyclun
    AustralianExecutive108584080002
    JEFFERSON, James Owen David
    Lodge Stockbriggs
    Lesmahagow
    ML11 0HN Lanark
    11
    Scotland
    Administrateur
    Lodge Stockbriggs
    Lesmahagow
    ML11 0HN Lanark
    11
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director72428180003
    KELLY, Brian Francis
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    England
    Administrateur
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    England
    EnglandBritishTraining Officer87917750001
    KELLY, Yvonne
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    Administrateur
    New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Third Floor, Priory Place
    Essex
    England
    EnglandBritishCollege Principal And Ceo248896580001
    KERSHAW, David
    38 St Peter's Square
    W6 9NW London
    Administrateur
    38 St Peter's Square
    W6 9NW London
    United KingdomBritishAdvertising44540920001
    LATHAM, Paul Robert
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    England
    Administrateur
    Production Park
    Purfleet Bypass
    RM19 1AS Purfleet
    The Backstage Centre High House
    Essex
    England
    EnglandBritishChief Operating Officer103647900001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    07 mai 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 26 août 2005
    Livré le 31 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum from time to time standing to the credit of a separate interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Team Brand Communication Consultants Limited
    Transactions
    • 31 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0