POP RETAIL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPOP RETAIL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05130940
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de POP RETAIL LIMITED ?

    • Location et location d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77390) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe POP RETAIL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o SHERRARDS SOLICITORS
    1-3 Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de POP RETAIL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RETAIL PROFILE EUROPE LIMITED20 juil. 200420 juil. 2004
    FAIRFAX SALON LIMITED18 mai 200418 mai 2004

    Quels sont les derniers comptes de POP RETAIL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour POP RETAIL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de Matthew John Bending en tant que directeur le 17 sept. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Inscription de la charge 051309400007, créée le 30 nov. 2018

    51 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gregor Rankin Dunlay le 22 mai 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Nancy Jane Cullen le 22 mai 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew John Bending le 22 mai 2017

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de POP RETAIL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUNLAY, Gregor Rankin
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    England
    Secrétaire
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    England
    155753260001
    CULLEN, Nancy Jane
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    England
    Administrateur
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    England
    United KingdomBritish72926330002
    DUNLAY, Gregor Rankin
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    England
    Administrateur
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    England
    ScotlandBritish113318710002
    LANGKRAEHR, Julia
    Flat 2
    10-16 Rathbone Street
    W1T 1NT London
    Secrétaire
    Flat 2
    10-16 Rathbone Street
    W1T 1NT London
    British105467470001
    THOMSON, Thomas Andrew
    14 South Drive
    RG40 2DH Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    14 South Drive
    RG40 2DH Wokingham
    Berkshire
    British121508200001
    RJP SECRETARIES LIMITED
    2 A C Court
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    2 A C Court
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    Surrey
    61999120002
    WJM SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    302
    Scotland
    Secrétaire
    St. Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    302
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC197245
    79915470001
    BENDING, Matthew John
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    England
    Administrateur
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    England
    United KingdomBritish75953430001
    BENNETT, Maurice
    9 Ingram Avenue
    NW11 6TG London
    Administrateur
    9 Ingram Avenue
    NW11 6TG London
    EnglandEnglish96696270001
    BENNETT, Michael
    Bedegars Lea Kenwood Close
    NW3 7JL London
    Administrateur
    Bedegars Lea Kenwood Close
    NW3 7JL London
    EnglandBritish2673650001
    CONSTABLE, Jamie Christopher
    15 Whitcomb Street
    WC2H 7HA London
    Administrateur
    15 Whitcomb Street
    WC2H 7HA London
    United KingdomBritish99708740001
    HELFGOTT, Maurice Harold
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    Administrateur
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    EnglandBritish67731320005
    KEMP, Martin Dunlop
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level Three
    United Kingdom
    Administrateur
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level Three
    United Kingdom
    EnglandBritish133534260001
    LANGKRAEHR, Julia
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    United Kingdom
    Administrateur
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish105467470001
    SARIN, Tony Deepak
    Flat 1 The Galleries
    9 Abbey Road
    NW8 9AQ London
    Administrateur
    Flat 1 The Galleries
    9 Abbey Road
    NW8 9AQ London
    EnglandBritish115493610001
    THOMSON, Thomas Andrew
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    United Kingdom
    Administrateur
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish121508200001
    WILSON, Kathleen
    60f Oxford Gardens
    W10 5UN London
    Administrateur
    60f Oxford Gardens
    W10 5UN London
    American91838490003
    JLS CORPORATE LIMITED
    2 A C Court
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    2 A C Court
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    Surrey
    88537630001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur POP RETAIL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    England
    06 avr. 2016
    Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06139685
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    POP RETAIL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2018
    Livré le 03 déc. 2018
    En cours
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 03 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 07 juil. 2011
    Livré le 09 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Trust debenture
    Créé le 24 mai 2010
    Livré le 28 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Maurice Helfgott (The Security Trustee)
    Transactions
    • 28 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 20 avr. 2007
    Livré le 28 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 oct. 2004
    Livré le 21 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2004
    Livré le 06 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly k/a fairfax salon limited to the chargee and any receiver on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all estates or interests in any f/h or l/h property all plant machinery all book and other debts goodwill and uncalled capital by way of first floating charge all its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aij Group Limited (The Creditor)
    Transactions
    • 06 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2004
    Livré le 06 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly k/a fairfax salon limited to the chargee and any receiver on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all estates or interests in any f/h or l/h property all plant machinery all book and other debts goodwill and uncalled capital by way of first floating charge all its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Quercus Enterprises Limited (The Creditor)
    Transactions
    • 06 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0