POP RETAIL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | POP RETAIL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05130940 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe POP RETAIL LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o SHERRARDS SOLICITORS 1-3 Pemberton Row EC4A 3BG London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de POP RETAIL LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour POP RETAIL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 16 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 16 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 17 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 20 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Matthew John Bending en tant que directeur le 17 sept. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 2 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 2 pages | MR04 | ||
Inscription de la charge 051309400007, créée le 30 nov. 2018 | 51 pages | MR01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 15 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gregor Rankin Dunlay le 22 mai 2017 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Nancy Jane Cullen le 22 mai 2017 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew John Bending le 22 mai 2017 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 18 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de POP RETAIL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNLAY, Gregor Rankin | Secrétaire | c/o Sherrards Solicitors Pemberton Row EC4A 3BG London 1-3 England | 155753260001 | |||||||||||
| CULLEN, Nancy Jane | Administrateur | c/o Sherrards Solicitors Pemberton Row EC4A 3BG London 1-3 England | United Kingdom | British | 72926330002 | |||||||||
| DUNLAY, Gregor Rankin | Administrateur | c/o Sherrards Solicitors Pemberton Row EC4A 3BG London 1-3 England | Scotland | British | 113318710002 | |||||||||
| LANGKRAEHR, Julia | Secrétaire | Flat 2 10-16 Rathbone Street W1T 1NT London | British | 105467470001 | ||||||||||
| THOMSON, Thomas Andrew | Secrétaire | 14 South Drive RG40 2DH Wokingham Berkshire | British | 121508200001 | ||||||||||
| RJP SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 2 A C Court High Street KT7 0SR Thames Ditton Surrey | 61999120002 | |||||||||||
| WJM SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland |
| 79915470001 | ||||||||||
| BENDING, Matthew John | Administrateur | c/o Sherrards Solicitors Pemberton Row EC4A 3BG London 1-3 England | United Kingdom | British | 75953430001 | |||||||||
| BENNETT, Maurice | Administrateur | 9 Ingram Avenue NW11 6TG London | England | English | 96696270001 | |||||||||
| BENNETT, Michael | Administrateur | Bedegars Lea Kenwood Close NW3 7JL London | England | British | 2673650001 | |||||||||
| CONSTABLE, Jamie Christopher | Administrateur | 15 Whitcomb Street WC2H 7HA London | United Kingdom | British | 99708740001 | |||||||||
| HELFGOTT, Maurice Harold | Administrateur | Kirkman House 12-14 Whitfield Street W1T 2RF London Level 3 | England | British | 67731320005 | |||||||||
| KEMP, Martin Dunlop | Administrateur | Kirkman House 12-14 Whitfield Street W1T 2RF London Level Three United Kingdom | England | British | 133534260001 | |||||||||
| LANGKRAEHR, Julia | Administrateur | Kirkman House 12-14 Whitfield Street W1T 2RF London Level 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 105467470001 | |||||||||
| SARIN, Tony Deepak | Administrateur | Flat 1 The Galleries 9 Abbey Road NW8 9AQ London | England | British | 115493610001 | |||||||||
| THOMSON, Thomas Andrew | Administrateur | Kirkman House 12-14 Whitfield Street W1T 2RF London Level 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 121508200001 | |||||||||
| WILSON, Kathleen | Administrateur | 60f Oxford Gardens W10 5UN London | American | 91838490003 | ||||||||||
| JLS CORPORATE LIMITED | Administrateur | 2 A C Court High Street KT7 0SR Thames Ditton Surrey | 88537630001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur POP RETAIL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Profile Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Sherrards Solicitors Pemberton Row EC4A 3BG London 1-3 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
POP RETAIL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 30 nov. 2018 Livré le 03 déc. 2018 | En cours | ||
Brève description N/A. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Créé le 07 juil. 2011 Livré le 09 juil. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trust debenture | Créé le 24 mai 2010 Livré le 28 mai 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 20 avr. 2007 Livré le 28 avr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 18 oct. 2004 Livré le 21 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 20 juil. 2004 Livré le 06 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company formerly k/a fairfax salon limited to the chargee and any receiver on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of first legal mortgage all estates or interests in any f/h or l/h property all plant machinery all book and other debts goodwill and uncalled capital by way of first floating charge all its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 20 juil. 2004 Livré le 06 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company formerly k/a fairfax salon limited to the chargee and any receiver on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of first legal mortgage all estates or interests in any f/h or l/h property all plant machinery all book and other debts goodwill and uncalled capital by way of first floating charge all its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0