PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED

PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05131340
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Southport Business Park
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EVER 2403 LIMITED18 mai 200418 mai 2004

    Quels sont les derniers comptes de PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ms Emma Jane Rawlinson en tant qu'administrateur le 13 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Rebecca Jane Shepherd en tant qu'administrateur le 13 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Byrne en tant que directeur le 01 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2021

    16 pagesAA

    legacy

    215 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 16 mai 2022 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Dean Clarke en tant que secrétaire le 22 févr. 2022

    1 pagesTM02

    Nomination de Ardonagh Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 22 févr. 2022

    2 pagesAP04

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2020

    16 pagesAA

    legacy

    195 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 01 juil. 2021

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Qui sont les dirigeants de PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement03702575
    288842300001
    EVANS, Robert Ieuan
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    Administrateur
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    United KingdomBritish257339940001
    RAWLINSON, Emma Jane
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United Kingdom
    Administrateur
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United Kingdom
    United KingdomBritish308195960001
    SHEPHERD, Rebecca Jane
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United Kingdom
    Administrateur
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandBritish191546550001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Secrétaire
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    169016440001
    CLARKE, Dean
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    253940220001
    EVANS, Paul William John
    2 Stokes Hall Avenue
    Leyland
    PR25 3FA Preston
    Lancashire
    Secrétaire
    2 Stokes Hall Avenue
    Leyland
    PR25 3FA Preston
    Lancashire
    British44044870002
    GIFFORD, Nicola
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Secrétaire
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    147962050001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Secrétaire
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    249087370001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Secrétaire
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    222330450001
    JOHNSTON, Graham Hamilton
    13 Glencairn Park Road
    GL50 2ND Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    13 Glencairn Park Road
    GL50 2ND Cheltenham
    Gloucestershire
    British120581050001
    OWENS, Jennifer
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Secrétaire
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    183285380001
    PENDER, Stuart Macpherson
    Dalnair House
    47 Chalton Road
    FK9 4EF Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    Secrétaire
    Dalnair House
    47 Chalton Road
    FK9 4EF Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    British86071320001
    POWELL, Vernon David
    18 Sunnybank Road
    Helmshore
    BB4 4PF Rossendale
    Lancashire
    Secrétaire
    18 Sunnybank Road
    Helmshore
    BB4 4PF Rossendale
    Lancashire
    British65823910002
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire désigné
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    BOULGER, Graham
    2 Church Gardens
    Euxton
    PR7 6LF Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    2 Church Gardens
    Euxton
    PR7 6LF Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish85225620001
    BYRNE, Jonathan
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    Administrateur
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    United KingdomBritish261430150001
    CHRISTOPHERS, Michael
    7 Chiltern Close
    Park Hill
    CR0 5LZ Croydon
    Surrey
    Administrateur
    7 Chiltern Close
    Park Hill
    CR0 5LZ Croydon
    Surrey
    British56738180003
    COWAN, John
    47 Montagu Square
    W1H 2LW London
    Administrateur
    47 Montagu Square
    W1H 2LW London
    United KingdomBritish109138540001
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish59873490009
    DAVIES, Mark
    12 Pinfold Lane
    PR8 3QH Ainsdale
    Merseyside
    Administrateur
    12 Pinfold Lane
    PR8 3QH Ainsdale
    Merseyside
    British117122470001
    DIXON, Richard John
    6 Woodthorpe Manor
    Sandal
    WF2 6SY Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    6 Woodthorpe Manor
    Sandal
    WF2 6SY Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish109138230001
    EGAN, Scott
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish169209310001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    United KingdomCypriot167795710001
    EVANS, Paul William John
    2 Stokes Hall Avenue
    Leyland
    PR25 3FA Preston
    Lancashire
    Administrateur
    2 Stokes Hall Avenue
    Leyland
    PR25 3FA Preston
    Lancashire
    British44044870002
    HODGES, Mark Steven
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish58444370003
    HOMER, Andrew Charles
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish13483140003
    JOHNSON, Timothy David
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish140206600001
    JOHNSTON, Graham Hamilton
    13 Glencairn Park Road
    GL50 2ND Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    13 Glencairn Park Road
    GL50 2ND Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish120581050001
    KENNEDY, Eamonn
    18 Lyme Road
    Disley
    SK12 2LL Stockport
    Administrateur
    18 Lyme Road
    Disley
    SK12 2LL Stockport
    EnglandBritish75039450002
    LANE SMITH, Roger
    The Lanebridge Property Fund
    The Coach House Fulshaw Hall
    SK9 1RL Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    The Lanebridge Property Fund
    The Coach House Fulshaw Hall
    SK9 1RL Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritish109062130001
    LYONS, Alastair David
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish192311310001
    MACIVER, Kenneth
    The Poplars
    The Green
    TN12 8JS Horsmonden
    Kent
    Administrateur
    The Poplars
    The Green
    TN12 8JS Horsmonden
    Kent
    British70920700002
    MARTIN, Kay Alison
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish228129420001
    MUGGE, Mark Stephen
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish162920630005

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Paymentshield Group Holdings Limited
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Cardiff
    Numéro d'enregistrement5919794
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 juin 2020
    Livré le 18 juin 2020
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Citibank, N.A., London Branch
    Transactions
    • 18 juin 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 sept. 2018
    Livré le 01 oct. 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Citibank, N.A., London Branch
    Transactions
    • 01 oct. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 août 2017
    Livré le 10 août 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Citibank, N.A., London Branch
    Transactions
    • 10 août 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 avr. 2015
    Livré le 22 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transactions
    • 22 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 mai 2013
    Livré le 20 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2012
    Livré le 06 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 06 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 11 févr. 2011
    Livré le 25 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 25 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 29 juin 2009
    Livré le 13 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 13 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 avr. 2009
    Livré le 06 mai 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 06 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 10 déc. 2007
    Livré le 21 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for and on Behalf of the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transactions
    • 21 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 nov. 2006
    Livré le 14 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aviva Insurance Limited
    Transactions
    • 14 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 nov. 2006
    Livré le 14 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal & Sun Aliance Insurance PLC
    Transactions
    • 14 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 août 2004
    Livré le 25 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting in Its Capacity as Security Trustee Forthe Security Beneficiaries the "Security Trustee"
    Transactions
    • 25 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over cash collateral account
    Créé le 13 août 2004
    Livré le 25 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the lng bank under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any credit balance on the secured account number 06037903 sort code 12-08-95 and all entitlements to interest the right to repayment and all other rights benefits and proceeds thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting in Its Capacity as Security Trustee Forand on Behalf of the Lng Bank the "Security Trustee"
    Transactions
    • 25 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0