MICRO FOCUS INTERNATIONAL LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MICRO FOCUS INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05134647 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MICRO FOCUS INTERNATIONAL LIMITED ?
Adresse du siège social | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MICRO FOCUS INTERNATIONAL LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MICRO FOCUS INTERNATIONAL LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 23 févr. 2026 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 09 mars 2026 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 23 févr. 2025 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MICRO FOCUS INTERNATIONAL LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Madhu Ranganathan en tant que directeur le 27 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
État du capital au 01 oct. 2024
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2023 | 31 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré The Lawn Old Bath Road Newbury Berkshire RG14 1QN | 1 pages | AD04 | ||||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 oct. 2023 au 30 juin 2023 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
État du capital au 22 sept. 2023
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Vente ou cession d'actions de trésorerie. Capital de trésorerie:
| 2 pages | SH04 | ||||||||||||||
Vente ou cession d'actions de trésorerie. Capital de trésorerie:
| 2 pages | SH04 | ||||||||||||||
Vente ou cession d'actions de trésorerie. Capital de trésorerie:
| 2 pages | SH04 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 29 juin 2023
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Inscription de la charge 051346470009, créée le 01 mai 2023 | 16 pages | MR01 | ||||||||||||||
Inscription de la charge 051346470006, créée le 01 mai 2023 | 14 pages | MR01 | ||||||||||||||
Inscription de la charge 051346470007, créée le 01 mai 2023 | 14 pages | MR01 | ||||||||||||||
Inscription de la charge 051346470008, créée le 01 mai 2023 | 14 pages | MR01 | ||||||||||||||
Vente ou cession d'actions de trésorerie. Capital de trésorerie:
| 2 pages | SH04 | ||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 oct. 2022 | 260 pages | AA | ||||||||||||||
Notification de Open Text Uk Holding Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2023 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de MICRO FOCUS INTERNATIONAL LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEDO, Michael Fernando | Secrétaire | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | 304922040001 | |||||||
WAIDA, Christian | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | Svp & General Counsel, Commercial Operations | 210176240001 | ||||
WILKINSON, Mark Kenneth | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Svp, Sales - Ecs Europe | 294482840001 | ||||
CHASE, Suzanne Gabrielle | Secrétaire | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | 270916530001 | |||||||
SMITHARD, Jane Caroline Grantham | Secrétaire | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | British | 131824970001 | ||||||
HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||
ASHE, Prescott | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | Usa | American | Investment Professional | 192881010001 | ||||
ASHE, Prescott Hillary | Administrateur | 2415 Bay Street San Francisco Ca94123 Usa | United States | Director | 104712190001 | |||||
ASHLEY, Matthew Edward | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Accountant | 284820350001 | ||||
ATKINS, Richard Charles | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Company Director | 104670700001 | ||||
BRAUCKMANN, Nils | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | Germany | German | Company Director | 204793010001 | ||||
BRAY, Nicholas Paul Seaton | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Finance Director | 110136340001 | ||||
BROWETT, John Julian | Administrateur | 10 Talbot Road Highgate N6 4QR London | United Kingdom | British | General Management | 125764240001 | ||||
BROWN, Amanda Victoria | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Group Human Resources Director | 199780290001 | ||||
CAMPBELL, Pauline Jane | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Non-Executive Director | 287985340001 | ||||
CLIFFORD, Nigel Richard | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Director | 72386960003 | ||||
DOMINIK, David Caldwell | Administrateur | 2733 Teton Pines Drive Wilson Wy83014 Usa | American | Director | 104711750001 | |||||
FITT, Lawton Wehle | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | United States | American | Director | 239749990001 | ||||
GEARY, Karen Mary | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Chief People Officer | 74821590001 | ||||
GOLOB, David Richard | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | Usa | American | Company Director | 126166560002 | ||||
HILL, Anthony Christopher, Dr | Administrateur | 4 Dorian Close HP23 5FH Tring Hertfordshire | England | British | Ceo | 34797090002 | ||||
HSU, Christopher Paul | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | United States | American | Ceo | 237643500001 | ||||
KELLY, Stephen Paul | Administrateur | Two Oaks, 36 Esher Park Avenue KT10 9NX Esher Surrey | England | British | Ceo | 69764380001 | ||||
KENNEDY, Christopher John | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Director | 62227310005 | ||||
LLOYD, Richard Brian | Administrateur | 15a Guessens Road AL8 6QL Welwyn Garden City Hertfordshire | England | British | Accountant | 44812880002 | ||||
LOCK, Gregory Hugh | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Director | 72742660005 | ||||
LOOSEMORE, Kevin | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Company Director | 123862930002 | ||||
MALONEY, David Ossian | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 69071800002 | ||||
MCARTHUR-MUSCROFT, Brian David | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Chief Financial Officer | 255768970001 | ||||
MURDOCH, Stephen Edward | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Ceo | 117638350002 | ||||
MURDOCH, Stephen Edward | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Company Director | 117638350002 | ||||
MURDOCH, Stephen Edward | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Company Director | 117638350001 | ||||
PESTER, Paul David, Dr | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Company Director | 155423590001 | ||||
PHILLIPS, Michael Scott | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | England | British | Finance Director | 59751680002 | ||||
POLISHOOK, Debra Ann | Administrateur | The Lawn Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire | United States | American | Non-Executive Director | 297541520001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MICRO FOCUS INTERNATIONAL LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Text Uk Holding Limited | 31 janv. 2023 | Thames Valley Park RG6 1PT Reading 420 Thames Valley Park Drive Berkshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0