BRAND NEW CO (225) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRAND NEW CO (225) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05137991
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRAND NEW CO (225) LIMITED ?

    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction

    Où se situe BRAND NEW CO (225) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7 St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRAND NEW CO (225) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BARDSLEY LIMITED12 août 200512 août 2005
    BRAND NEW CO (225) LIMITED26 mai 200426 mai 2004

    Quels sont les derniers comptes de BRAND NEW CO (225) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BRAND NEW CO (225) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    16 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 avr. 2020

    14 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 avr. 2019

    16 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 avr. 2018

    17 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Globe Square Dukinfield Cheshire SK16 4RG à 7 st. Petersgate Stockport Cheshire SK1 1EB le 11 mai 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 26 avr. 2017

    LRESEX

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name09 sept. 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juin 2016

    État du capital au 20 juin 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    15 pagesAA

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2014 au 30 juin 2015

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juin 2015

    État du capital au 16 juin 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Graeme Spencer en tant que directeur le 30 juin 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 juin 2014

    État du capital au 13 juin 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Graeme Spencer le 26 mai 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Roland Bardsley le 26 mai 2014

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Robert Edmund Paul Bodnar-Horvath en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Neil Macdougal en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de BRAND NEW CO (225) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARDSLEY, Roland
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    Administrateur
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    United KingdomBritish140518810002
    BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    Administrateur
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    EnglandBritish46232460002
    RAFTERY, Paul Matthew
    9 Redcourt Avenue
    M20 3QL Manchester
    Secrétaire
    9 Redcourt Avenue
    M20 3QL Manchester
    British62586740002
    STUBLEY, Caroline
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    Secrétaire
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    British163442060001
    MACDOUGAL, Neil Charles
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish93401120003
    MCCARREN, Lee Scott
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish107908930001
    PURKIS, Stephen Robert
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    Administrateur
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    EnglandBritish135467600002
    SPENCER, Graeme
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    Administrateur
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    EnglandBritish140712180002
    STUBLEY, Caroline
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    Administrateur
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    United KingdomBritish163442060001
    THOMPSON, Alan Christopher
    21a Spath Road
    Didsbury
    M20 2QT Manchester
    Greater Manchester
    Administrateur
    21a Spath Road
    Didsbury
    M20 2QT Manchester
    Greater Manchester
    United KingdomBritish39558890001

    BRAND NEW CO (225) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 05 mai 2011
    Livré le 11 mai 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 11 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Blocked account charge
    Créé le 08 avr. 2010
    Livré le 15 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit being all or any of the amounts of the blocked account charge numbered 39139336 with sort code 01-05-31 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 23 nov. 2007
    Livré le 28 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings lying to the south side of worsley road worsley manchester (t/no GM138828) and all that land shown edged red on plan 2 annexed to the deed and all that land shown edged red on plan. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 11 juil. 2006
    Livré le 19 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h land on the east side of mottram old road stalybridge t/n GM118130,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 17 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM952048 and all that f/h land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM945234. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 10 nov. 2004
    Livré le 15 nov. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)

    BRAND NEW CO (225) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 oct. 2021Due to be dissolved on
    26 avr. 2017Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Vincent Andrew Simmons
    7 St Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire
    practitioner
    7 St Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0