BRAND NEW CO (225) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BRAND NEW CO (225) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05137991 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BRAND NEW CO (225) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 7 St. Petersgate SK1 1EB Stockport Cheshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BRAND NEW CO (225) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour BRAND NEW CO (225) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 16 pages | LIQ14 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 avr. 2020 | 14 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 avr. 2019 | 16 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 avr. 2018 | 17 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Globe Square Dukinfield Cheshire SK16 4RG à 7 st. Petersgate Stockport Cheshire SK1 1EB le 11 mai 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché | 5 pages | 4.20 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2015 | 15 pages | AA | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2014 au 30 juin 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 15 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Graeme Spencer en tant que directeur le 30 juin 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Graeme Spencer le 26 mai 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Roland Bardsley le 26 mai 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Edmund Paul Bodnar-Horvath en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neil Macdougal en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BRAND NEW CO (225) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDSLEY, Roland | Administrateur | St. Petersgate SK1 1EB Stockport 7 Cheshire | United Kingdom | British | 140518810002 | |||||
| BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul | Administrateur | St. Petersgate SK1 1EB Stockport 7 Cheshire | England | British | 46232460002 | |||||
| RAFTERY, Paul Matthew | Secrétaire | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | 62586740002 | ||||||
| STUBLEY, Caroline | Secrétaire | 4 Limewood Meadow Church Road M29 7UZ Astley | British | 163442060001 | ||||||
| MACDOUGAL, Neil Charles | Administrateur | The Garden House Off Chester Road, Tabley WA16 OHA Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 93401120003 | |||||
| MCCARREN, Lee Scott | Administrateur | Chadwicks Close Farm Off Coal Pit Road Smithills BL1 7PB Bolton Lancashire | England | British | 107908930001 | |||||
| PURKIS, Stephen Robert | Administrateur | Globe Square Dukinfield SK16 4RG Cheshire | England | British | 135467600002 | |||||
| SPENCER, Graeme | Administrateur | Globe Square Dukinfield SK16 4RG Cheshire | England | British | 140712180002 | |||||
| STUBLEY, Caroline | Administrateur | 4 Limewood Meadow Church Road M29 7UZ Astley | United Kingdom | British | 163442060001 | |||||
| THOMPSON, Alan Christopher | Administrateur | 21a Spath Road Didsbury M20 2QT Manchester Greater Manchester | United Kingdom | British | 39558890001 |
BRAND NEW CO (225) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 05 mai 2011 Livré le 11 mai 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Blocked account charge | Créé le 08 avr. 2010 Livré le 15 avr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The deposit being all or any of the amounts of the blocked account charge numbered 39139336 with sort code 01-05-31 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 23 nov. 2007 Livré le 28 nov. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings lying to the south side of worsley road worsley manchester (t/no GM138828) and all that land shown edged red on plan 2 annexed to the deed and all that land shown edged red on plan. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 11 juil. 2006 Livré le 19 juil. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h land on the east side of mottram old road stalybridge t/n GM118130,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 17 oct. 2005 Livré le 27 oct. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM952048 and all that f/h land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM945234. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 10 nov. 2004 Livré le 15 nov. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
BRAND NEW CO (225) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0