REGNUM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREGNUM LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05145864
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REGNUM LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe REGNUM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Opet International Ltd 3rd Floor
    35 Dover Street
    W1S 4NQ London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de REGNUM LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour REGNUM LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au04 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation18 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au04 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour REGNUM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2023

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Opet International Ltd 4th Floor 180 Piccadilly St James's London W1J 9ER United Kingdom à C/O Opet International Ltd 3rd Floor 35 Dover Street London W1S 4NQ le 12 janv. 2024

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Ismail Mufit Alpsu en tant que secrétaire le 10 janv. 2022

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 76 Hotham Road London SW15 1QP United Kingdom à C/O Opet International Ltd 4th Floor 180 Piccadilly St James's London W1J 9ER le 18 janv. 2022

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    9 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 54-56 Great Suffolk Street London SE1 0BL à 76 Hotham Road London SW15 1QP le 08 juil. 2021

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juin 2016

    État du capital au 07 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Harben House Harben Parade Finchley Road London NW3 6LH

    1 pagesAD03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2015

    État du capital au 05 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Qui sont les dirigeants de REGNUM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OZTURK, Ali Safak
    3rd Floor
    35 Dover Street
    W1S 4NQ London
    C/O Opet International Ltd
    United Kingdom
    Administrateur
    3rd Floor
    35 Dover Street
    W1S 4NQ London
    C/O Opet International Ltd
    United Kingdom
    United KingdomTurkish,BritishInvestor119271570002
    ALPSU, Ismail Mufit
    4th Floor 180 Piccadilly
    St James's
    W1J 9ER London
    C/O Opet International Ltd
    United Kingdom
    Secrétaire
    4th Floor 180 Piccadilly
    St James's
    W1J 9ER London
    C/O Opet International Ltd
    United Kingdom
    British113466450002
    BHARDWAJ, Ashok
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    Secrétaire désigné
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    British900010640001
    BOSTAN, Sahin Sener
    104 Southbury Road
    EN1 1YD Enfield
    Middlesex
    Secrétaire
    104 Southbury Road
    EN1 1YD Enfield
    Middlesex
    BritishCo Sec46025860002
    OZTURK, Fikret
    Bulgurlu Mah
    Sarigazi Cad. No. 47, Uskudar
    Istanbul 81190
    Turkey
    Administrateur
    Bulgurlu Mah
    Sarigazi Cad. No. 47, Uskudar
    Istanbul 81190
    Turkey
    TurkeyTurkishCo Dir99643850003
    OZTURK, Ufuk
    1 Northumberland Avenue
    Trafalgar Square
    WC2N 5BW London
    Unit 201
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Northumberland Avenue
    Trafalgar Square
    WC2N 5BW London
    Unit 201
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestor150494710001
    BHARDWAJ CORPORATE SERVICES LIMITED
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    Administrateur désigné
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    900010630001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REGNUM LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Ali Safak Ozturk
    3rd Floor
    35 Dover Street
    W1S 4NQ London
    C/O Opet International Ltd
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    3rd Floor
    35 Dover Street
    W1S 4NQ London
    C/O Opet International Ltd
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: Turkish,British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    REGNUM LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of debenture
    Créé le 28 août 2012
    Livré le 10 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H 55 royal mint street and land adjacent thereto, and 56 royal mint street london t/no EGL454018 fixed and floating charge over the undertaking and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Europe Arab Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 02 nov. 2010
    Livré le 04 nov. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    6 wheler street london by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • Turkish Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 04 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage
    Créé le 07 avr. 2010
    Livré le 08 avr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    164 nine ashes road, nine ashes, ingatestone and all other assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Turkish Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 08 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 01 avr. 2008
    Livré le 09 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    £1,000,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land k/a development site on the corner of john fisher street and royal mint street london the gross rents licence fees and other moneys by way of floating charge the undertaking and all other property assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Turkish Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 09 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Security deposit deed
    Créé le 03 avr. 2006
    Livré le 07 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    £42,881.63, due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    £42,881.63.
    Personnes ayant droit
    • The Western Heritable Investment Company Limited
    Transactions
    • 07 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 14 oct. 2005
    Livré le 19 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property at 253-257 westferry road, london t/no EGL440877 and the proceeds of sale thereof and the proceeds of any policy of insurance, by way of floating security all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other materials goods and other effects now or from time to time placed on or used in or about the property, all goodwill and connection of any business or businesses from time to time carried on in or upon the said property and the benefit of all licences held in connection with such business.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Co.
    Transactions
    • 19 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 oct. 2005
    Livré le 19 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Co.
    Transactions
    • 19 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0