WHITE STAR LEISURE PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHITE STAR LEISURE PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 05147351
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHITE STAR LEISURE PLC ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe WHITE STAR LEISURE PLC ?

    Adresse du siège social
    C/O Libertas 3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WHITE STAR LEISURE PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WHITE STAR ENERGY PLC10 mars 200910 mars 2009
    WHITE STAR PROPERTY HOLDINGS PLC16 févr. 200616 févr. 2006
    EURO CAPITAL PROJECTS PLC22 juin 200422 juin 2004
    ORIENTROSE 4 PLC07 juin 200407 juin 2004

    Quels sont les derniers comptes de WHITE STAR LEISURE PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour WHITE STAR LEISURE PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    13 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 déc. 2023

    24 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 07 déc. 2021

    LRESEX

    Déclaration des affaires

    18 pagesLIQ02

    Changement d'adresse du siège social de Milner House 14 Manchester Square London W1U 3PP England à C/O Libertas 3 Chandler House, Hampton Mews 191-195 Sparrows Herne Bushey Hertfordshire WD23 1FL le 15 déc. 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 24 sept. 2021 avec mises à jour

    16 pagesCS01

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 10 sept. 2020

    20 pagesRP04CS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    19 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Lucy Kathleen Jewell le 25 nov. 2020

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Limestar Investments Limited le 19 nov. 2020

    1 pagesCH04

    Modification des détails de Mr Geoffrey Hugh Melamet en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 nov. 2020

    2 pagesPSC04

    10/09/20 Statement of Capital gbp 3046694.996

    21 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    24 févr. 2021Clarification A second filed CS01(amending Statement of capital and shareholder information) was registered on 24/02/2021.

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2019 avec mises à jour

    23 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 août 2018 avec mises à jour

    26 pagesCS01

    Cessation de Keith Leslie Atkinson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 janv. 2018

    3 pagesPSC07

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    21 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor 3 Crawford Place London W1H 4LB England à Milner House 14 Manchester Square London W1U 3PP le 20 juil. 2018

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2017 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 juil. 2016 avec mises à jour

    61 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Hmsa Ltd 100 Seymour Place London W1H 1NE England à 1st Floor 3 Crawford Place London W1H 4LB le 24 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de WHITE STAR LEISURE PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LIMESTAR INVESTMENTS LIMITED
    14 Manchester Square
    W1U 3PP London
    Milner House
    England
    Secrétaire
    14 Manchester Square
    W1U 3PP London
    Milner House
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement2268111
    94206670002
    JEWELL, Lucy Kathleen
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    EnglandBritish182337000002
    MELAMET, Geoffrey Hugh
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    United KingdomBritish2209360001
    ATKINSON, Keith Leslie
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    Secrétaire
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    188932750001
    FARMILOE, Andrew Derrick John
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    Secrétaire
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    190663650001
    MAY, Graham Philip
    Floor 36
    Spital Square
    E1 6DY London
    4th
    England
    Secrétaire
    Floor 36
    Spital Square
    E1 6DY London
    4th
    England
    177961300001
    NICHOLLS, Vincent William
    Winkhurst Farmhouse
    Coopers Corner Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Winkhurst Farmhouse
    Coopers Corner Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    British124916980001
    ROUZEL, Alan Keith
    88 Montrose Avenue
    HA8 0DR Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    88 Montrose Avenue
    HA8 0DR Edgware
    Middlesex
    British55714880001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Secrétaire
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    76729800001
    CONGRESS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St John's Road
    HA1 2EY Harrow
    7
    Middlesex
    Secrétaire
    St John's Road
    HA1 2EY Harrow
    7
    Middlesex
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03525413
    293584180001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secrétaire désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    ALLEN, Robert Keith
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    EnglandEnglish44871030002
    ATKINSON, Keith Leslie
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    Administrateur
    The Hollies
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Holt
    West Sussex
    England
    United KingdomBritish80263550003
    BASHAM, Brian Arthur
    Elsworthy Rise
    NW3 3SH London
    14
    Administrateur
    Elsworthy Rise
    NW3 3SH London
    14
    United KingdomBritish69378240003
    DEAN, Stephen
    610 Euro Tower
    Europort Road
    Gibraltar
    Administrateur
    610 Euro Tower
    Europort Road
    Gibraltar
    British103038770001
    DEAN, Stephen
    311 Portland House
    Glacis Road
    FOREIGN Gibraltar
    Administrateur
    311 Portland House
    Glacis Road
    FOREIGN Gibraltar
    British76827800002
    GARVIN, Michael Samuel Philip
    Flat 7
    103-105 Harley Street
    W1G 6AJ London
    Administrateur
    Flat 7
    103-105 Harley Street
    W1G 6AJ London
    United KingdomBritish49337220002
    GIL, Alberto Manuel
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    EnglandBritish99545050002
    HALL, Mark Andrew
    Sambourne Road
    BA12 8LL Warminster
    39
    Wiltshire
    England
    Administrateur
    Sambourne Road
    BA12 8LL Warminster
    39
    Wiltshire
    England
    United KingdomBritish166498830001
    HAND, John Lester
    7 Ordnance Hill
    NW8 6PR London
    Administrateur
    7 Ordnance Hill
    NW8 6PR London
    EnglandBritish98898900001
    HEMINGWAY, John
    The Oast House
    Delaware Farm, Hever Road
    TN8 7LD Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    The Oast House
    Delaware Farm, Hever Road
    TN8 7LD Edenbridge
    Kent
    British76213390009
    LLOYD COOPER, Peter Ross
    5 Westmoreland Place
    SW1V 4AB London
    Administrateur
    5 Westmoreland Place
    SW1V 4AB London
    UkBritish56679430001
    NASH, Michael Raymond
    8 Parkinson Close
    AL4 8DP Wheathampstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Parkinson Close
    AL4 8DP Wheathampstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish28045530003
    NICHOLLS, Vincent William
    Winkhurst Farmhouse
    Coopers Corner Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Winkhurst Farmhouse
    Coopers Corner Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish124916980001
    RISBEY, David John
    Baarerstrasse 75
    Zug
    6302
    Switzerland
    Administrateur
    Baarerstrasse 75
    Zug
    6302
    Switzerland
    Swiss113720350001
    TENUTA, Luca
    Flat 6
    39 Sutherland Avenue
    W9 2HE London
    Administrateur
    Flat 6
    39 Sutherland Avenue
    W9 2HE London
    United KingdomItalian119743150002
    TURPIN, Carl Stephen
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    4th Floor
    England
    United KingdomBritish85268420001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Administrateur
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    76729800001
    CROFT NOMINEES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Administrateur
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    71126780002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WHITE STAR LEISURE PLC ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Keith Leslie Atkinson
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Hoft The Hollies
    West Sussex
    United Kingdom
    05 juil. 2016
    Chalcraft Lane
    PO21 5SX Bognor Regis
    The Hoft The Hollies
    West Sussex
    United Kingdom
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mr Geoffrey Hugh Melamet
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    05 juil. 2016
    3 Chandler House, Hampton Mews
    191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    C/O Libertas
    Hertfordshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    WHITE STAR LEISURE PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 09 juin 2010
    Livré le 22 juin 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Zengreen Limited
    Transactions
    • 22 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 17 juil. 2007
    Livré le 19 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £631,788.01 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    F/H property k/a 1 park road hackbridge t/no SGL388585.
    Personnes ayant droit
    • Stephen Oliver Brook and Michael Maurice Martin
    Transactions
    • 19 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 09 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 28 mars 2007
    Livré le 03 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All securities, all dividends interest and other distributions and all accretions rights benefits money or property accruing issued or offered in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 nov. 2006
    Livré le 30 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mars 2006
    Livré le 11 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All book and other debts the benefit of all rights relating to the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dcf (UK) Limited
    Transactions
    • 11 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WHITE STAR LEISURE PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 mai 2024Due to be dissolved on
    07 déc. 2021Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Barnett
    3 Chandlers House Hampton Mews 191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    Hertfordshire
    practitioner
    3 Chandlers House Hampton Mews 191-195 Sparrows Herne
    WD23 1FL Bushey
    Hertfordshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0