INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED

INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05156075
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O 39 Castle Street
    LE1 5WN Leicester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ACRE 899 LIMITED17 juin 200417 juin 2004

    Quels sont les derniers comptes de INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mars 2016

    12 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    11 pages4.72

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 01 avr. 2015

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de 27 Harley Street London W1G 9QP England à C/O 39 Castle Street Leicester LE1 5WN le 08 avr. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    13 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Entrance a Tavistock House Tavistoke Square London WC1H 9LG à 27 Harley Street London W1G 9QP le 01 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 juin 2014

    État du capital au 18 juin 2014

    • Capital: GBP 13,010
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Gloria Pope en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Andrew Andreou en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    14 pagesAA

    Nomination de Mr Paul Simon Thompson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 17 juin 2010

    21 pagesRP04

    Cessation de la nomination de David Laing en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Karen Anne Miller en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    15 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    23 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EL SEIF, Sultan Mohammed
    Tavistock House
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Entrance A
    Administrateur
    Tavistock House
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Entrance A
    Kingdom Of Saudi ArabiaSaudi ArabianCompany Director149448840001
    KANDIAH, Senthilnathan
    Holmwood
    18b Kingsdowne Road
    KT6 6JZ Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    Holmwood
    18b Kingsdowne Road
    KT6 6JZ Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant41830510001
    MILLER, Karen Anne
    Tavistock House
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Entrance A
    United Kingdom
    Administrateur
    Tavistock House
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Entrance A
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director171622490001
    THOMPSON, Paul Simon
    Tavistock House
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Entrance A
    United Kingdom
    Administrateur
    Tavistock House
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Entrance A
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director171448700001
    KANDIAH, Senthilnathan
    Holmwood
    18b Kingsdowne Road
    KT6 6JZ Surbiton
    Surrey
    Secrétaire
    Holmwood
    18b Kingsdowne Road
    KT6 6JZ Surbiton
    Surrey
    BritishAccountant41830510001
    POPE, Gloria June
    39 Plumer Road
    HP11 2SS High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    39 Plumer Road
    HP11 2SS High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishSecretary74800230001
    LAWSON (LONDON) LIMITED
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Secrétaire désigné
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    900018120001
    ANDREOU, Andrew
    3 Stormont Road
    N6 4NS London
    Administrateur
    3 Stormont Road
    N6 4NS London
    United KingdomBritishDirector75380960003
    BARKER, Peter Gerard, Dr
    Brook Street Farm
    TN8 5NH Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    Brook Street Farm
    TN8 5NH Edenbridge
    Kent
    EnglandBritishHospital Consultant77796960002
    DEXTER, Alan Michael
    42 Stone Hall Road
    Winchmore Hill
    N21 1LP London
    Administrateur
    42 Stone Hall Road
    Winchmore Hill
    N21 1LP London
    EnglandBritishDirector32438340001
    HARRIS, Robert Llewellyn
    31 Montefiore Street
    Battersea
    SW8 3TP London
    Administrateur
    31 Montefiore Street
    Battersea
    SW8 3TP London
    BritishAccountant/Finance Director121362030001
    LAING, David
    Tavistock House
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Entrance A
    United Kingdom
    Administrateur
    Tavistock House
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Entrance A
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director149448470001
    THORLEY, Ian
    Bolton Gardens
    SW5 0AJ London
    4-18
    Administrateur
    Bolton Gardens
    SW5 0AJ London
    4-18
    United KingdomAustralianDirector131367730001
    VIRESWER, Selvavinayagam
    9 Alwyne Mansions
    Alwyne Road
    SW19 7AD London
    Administrateur
    9 Alwyne Mansions
    Alwyne Road
    SW19 7AD London
    BritishCompany Director100434820001
    ACRE (CORPORATE DIRECTOR) LIMITED
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Administrateur désigné
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    900021510001

    INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 août 2008
    Livré le 02 sept. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 21 août 2008
    Livré le 22 août 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 22 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 04 nov. 2005
    Livré le 11 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from four oaks associates limited to the chargee
    Brèves mentions
    All that agreement for lease dated 26 october 2005 and the benefit of the same and all the premises and interest in every conveyance tansfer or lease which may be granted. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of pledge over a deposit
    Créé le 17 mai 2005
    Livré le 27 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All sums outstanding at the credit of account number 06024485 together with all interest benefits and bonuses due thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2005
    Livré le 22 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    INSIGHT MEDICAL VENTURES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 avr. 2015Commencement of winding up
    30 juin 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Neil Charles Money
    39 Castle Street
    LE1 5WN Leicester
    practitioner
    39 Castle Street
    LE1 5WN Leicester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0