PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD

PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05188033
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD ?

    • fabrication de produits pharmaceutiques de base (21100) / Industries manufacturières

    Où se situe PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD ?

    Adresse du siège social
    Windmill Industrial Estate
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Northumberland
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AESICA PHARMACEUTICALS LIMITED17 août 200417 août 2004
    EVER 2414 LIMITED23 juil. 200423 juil. 2004

    Quels sont les derniers comptes de PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au14 juil. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation28 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au14 juil. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Satisfaction de la charge 051880330024 en totalité

    1 pagesMR04

    État du capital après une attribution d'actions au 25 juin 2024

    • Capital: GBP 876,500.78
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    28 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    30 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Windmill Industrial Estate Shotton Lane Cramlington Northumberland NE23 3JL

    1 pagesAD04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    41 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr. Stephen Christopher Lewinton le 07 janv. 2022

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Stephen Christopher Lewinton le 07 janv. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dr. Boliang Lou le 07 janv. 2022

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2022 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Aesica Pharmaceuticals Limited Windmill Industrial Estate Shotton Lane Cramlington Northumberland NE23 3JL England à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    1 pagesAD02

    Statuts

    28 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    3 pagesSH10

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    44 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Change of company name 07/01/2022
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Cessation de Consort Medical Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 janv. 2022

    1 pagesPSC07

    Notification de Pharmaron Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 janv. 2022

    2 pagesPSC02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Stephen Christopher Lewinton le 07 janv. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr. Stephen Christopher Lewinton le 07 janv. 2022

    1 pagesCH03

    Statuts

    13 pagesMA

    Qui sont les dirigeants de PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEWINTON, Stephen Christopher, Mr.
    Hertford Road
    EN11 9FH Hoddesdon
    West Hill Innovation Park
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hertford Road
    EN11 9FH Hoddesdon
    West Hill Innovation Park
    Hertfordshire
    United Kingdom
    291168170001
    LEWINTON, Stephen Christopher, Mr.
    Hertford Road
    EN11 9FH Hoddesdon
    West Hill Innovation Park
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hertford Road
    EN11 9FH Hoddesdon
    West Hill Innovation Park
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Vice President69459790004
    LOU, Boliang, Dr
    Tai-He Road
    Beijing Economic Technological Development Area
    100176 Beijing
    6
    China
    Administrateur
    Tai-He Road
    Beijing Economic Technological Development Area
    100176 Beijing
    6
    China
    United StatesAmericanCeo274855010003
    HAYES, Paul Andrew
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    243808710001
    ILETT, John Edward
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    202399490001
    JACKSON, Andrew Leonard
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Windmill Industrial Estate
    Northumberland
    England
    Secrétaire
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Windmill Industrial Estate
    Northumberland
    England
    250537500001
    JONES, Nick
    c/o Nick Jones (Cfo)
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Tyne & Wear
    England
    Secrétaire
    c/o Nick Jones (Cfo)
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Tyne & Wear
    England
    147287340001
    SIMS, Adam Duncan
    Laburnum House
    Corbridge Road
    NE46 1UN Hexham
    Northumberland
    Secrétaire
    Laburnum House
    Corbridge Road
    NE46 1UN Hexham
    Northumberland
    BritishCompany Director100043170002
    WARD, Iain Stuart
    c/o Ian Ward
    Aesica Pharmaceuticals, Q5
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5, Quorum Business Park
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Ian Ward
    Aesica Pharmaceuticals, Q5
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5, Quorum Business Park
    United Kingdom
    192885190001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire désigné
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    AVERY, Paul John
    c/o Ian Ward
    Aesica Pharmaceuticals, Q5
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5, Quorum Business Park
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Ian Ward
    Aesica Pharmaceuticals, Q5
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5, Quorum Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Financial Controller192867050001
    BOERMAN, Manja Hermina Elisabeth Maria, Dr
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    NetherlandsDutchDirector232164260001
    BROWN, Tom
    Tibthorpe Grange
    YO25 9LG Driffield
    East Yorkshire
    Administrateur
    Tibthorpe Grange
    YO25 9LG Driffield
    East Yorkshire
    BritishDirector100182380001
    COTTON, Richard John
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishCfo170307480002
    DODS, Samuel Charles
    6 High View Avenue
    Keyworth
    NG12 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    6 High View Avenue
    Keyworth
    NG12 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector100524680001
    ELDERED, Thomas Bengt
    Box 603
    101 32 Stockholm
    Recipharm Ab (Publ)
    Sweden
    Administrateur
    Box 603
    101 32 Stockholm
    Recipharm Ab (Publ)
    Sweden
    SwedenSwedishCeo266996040001
    GLENN, Jonathan Martin
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishCeo148251560003
    GOWLAND, Christopher David
    c/o Ian Ward
    Aesica Pharmaceuticals, Q5
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5, Quorum Business Park
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Ian Ward
    Aesica Pharmaceuticals, Q5
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5, Quorum Business Park
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director152709010001
    GOWLAND, Christopher David
    Windmill Industrial Estate
    Cramlington
    NE23 3JL Northumberland
    Administrateur
    Windmill Industrial Estate
    Cramlington
    NE23 3JL Northumberland
    United KingdomBritishDirector152709010001
    GOWLAND, Christopher
    10 Bellgreen Avenue
    Melton Park Gosforth
    NE3 5QR Newcastle
    Administrateur
    10 Bellgreen Avenue
    Melton Park Gosforth
    NE3 5QR Newcastle
    BritishCompany Director94947730001
    HARDY, Robert, Dr
    c/o Nick Jones (Cfo)
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Tyne & Wear
    England
    Administrateur
    c/o Nick Jones (Cfo)
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Tyne & Wear
    England
    United KingdomBritishCompany Director97702700002
    HARRISON, Steven Richard
    54 Uppelby
    Eastingwold
    YO61 3BB York
    Hillside
    Yorkshire
    England
    Administrateur
    54 Uppelby
    Eastingwold
    YO61 3BB York
    Hillside
    Yorkshire
    England
    EnglandBritishNon Executive Director135203380001
    HAYES, Paul Andrew
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishDirector160870900001
    HUNNYBALL, Ian Michael, Professor
    38 Coopers Lane
    OX14 5GW Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    38 Coopers Lane
    OX14 5GW Abingdon
    Oxfordshire
    BritishDirector123789680001
    JONES, Nicholas Vaughan
    c/o Nick Jones (Cfo)
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Tyne & Wear
    England
    Administrateur
    c/o Nick Jones (Cfo)
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Tyne & Wear
    England
    United KingdomBritishChief Financial Officer142787990001
    LEACH, Andy
    1 Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    8th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    8th Floor
    United Kingdom
    BritishVenture Capitalist134856460001
    MACKENZIE, David Arthur
    New Fetter Lane
    EC4A 1HH London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    New Fetter Lane
    EC4A 1HH London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector156668820001
    MCCONNELL, John Martin
    c/o Nick Jones (Cfo)
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Tyne & Wear
    England
    Administrateur
    c/o Nick Jones (Cfo)
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Tyne & Wear
    England
    United KingdomBritishCompany Director153171460001
    MCCONNELL, John
    Windmill Industrial Estate
    Cramlington
    NE23 3JL Northumberland
    Administrateur
    Windmill Industrial Estate
    Cramlington
    NE23 3JL Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director148373560001
    MUIR, Ian Stuart
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishManaging Director192862540001
    PALMER, Jarrett Vincent
    c/o Ian Ward
    Aesica Pharmaceuticals, Q5
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5, Quorum Business Park
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Ian Ward
    Aesica Pharmaceuticals, Q5
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5, Quorum Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritishOperations Director177841860001
    PARKER, John Francis
    Windmill Industrial Estate
    Cramlington
    NE23 3JL Northumberland
    Administrateur
    Windmill Industrial Estate
    Cramlington
    NE23 3JL Northumberland
    UkBritishConsultant117114820002
    PLUTA, Bernard
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Windmill Industrial Estate
    Northumberland
    England
    Administrateur
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Windmill Industrial Estate
    Northumberland
    England
    FranceFrenchPresident - Development Services282418370001
    QUICK, Mark Royston
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Windmill Industrial Estate
    Northumberland
    England
    Administrateur
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Windmill Industrial Estate
    Northumberland
    England
    EnglandBritishEvp Corporate Development124779290002
    RANKIN, Alan
    75 Swaledale Gardens
    High Heaton
    NE7 7TB Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    75 Swaledale Gardens
    High Heaton
    NE7 7TB Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director94947700001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Pharmaron Uk Limited
    Nettlefold Road
    CF24 5JQ Cardiff
    The Old Glassworks
    Wales
    07 janv. 2022
    Nettlefold Road
    CF24 5JQ Cardiff
    The Old Glassworks
    Wales
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006, England And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House, England And Wales
    Numéro d'enregistrement08755111
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    North Lynn Industrial Estate
    PE30 2JJ King's Lynn
    Bergen Way
    Norfolk
    England
    20 oct. 2020
    North Lynn Industrial Estate
    PE30 2JJ King's Lynn
    Bergen Way
    Norfolk
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00406711
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    North Lynn Industrial Estate
    PE30 2JJ King's Lynn
    Bergen Way
    Norfolk
    England
    06 avr. 2016
    North Lynn Industrial Estate
    PE30 2JJ King's Lynn
    Bergen Way
    Norfolk
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement7707393
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    PHARMARON MANUFACTURING SERVICES (UK) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 mars 2021
    Livré le 08 mars 2021
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 mars 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 nov. 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 mai 2014
    Livré le 03 juin 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 03 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 mai 2014
    Livré le 03 juin 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 03 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 21 mars 2014
    Livré le 25 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H land and buildings on the east and west sides of shotton lane cramlington northumberland t/no ND27479, f/h land on the west side of whiteway road t/no K117105 and f/h land and buildings on the west side of whiteway road t/no K112997 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 25 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge confirmation and new pledge agreement
    Créé le 11 oct. 2012
    Livré le 01 nov. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the parent, the company and/or any other obligor to the security agent and/or a finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledgors shares meaning the 25,000 shares in the amount of eur 1.00, dividends, liquidation proceeds see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as the Security Agent for the Original Pledgees) and the Original Pledgees
    Transactions
    • 01 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of acknowledgement and extension of pledge over quota created outside of the united kingdom over property situated outside of the united kingdom
    Créé le 11 oct. 2012
    Livré le 01 nov. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the existing and future options in respect of the pledged quota; all the distributions in respect.of the pledged quota in connection with the liquidation of aesica pharmaceuticals S.r/l, or reduction of its capital see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Security Beneficiary
    Transactions
    • 01 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Keyman insurance assignment
    Créé le 12 déc. 2011
    Livré le 14 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    An insurance policy with friends life (formerly bupa health assurance LTD) p/no H253083801 in respect of the life of chris gowland for the sum of £250,000. an insurance policy with friends life (formerly bupa health assurance LTD) p/no H253085401 in respect of the life of robert hardy for the sum of £1,000,000 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Agent) (in Its Capacity as Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 14 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge agreement
    Créé le 11 oct. 2011
    Livré le 26 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the parent, the company and/or any other obligor to the security agent and/or a finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledgors shares, dividends, liquidation proceeds see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as the Security Agent for the Pledgees
    Transactions
    • 26 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Pledge over quota executed outside of the united kingdom over property situated outside of the united kingdom
    Créé le 11 oct. 2011
    Livré le 22 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the existing and future options in respect of the pledged quota; all the distributions and dividends in respect. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Security Beneficiaries
    Transactions
    • 22 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 11 oct. 2011
    Livré le 13 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currency unit, and the debt or debts from time to time.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession to debenture
    Créé le 11 oct. 2011
    Livré le 13 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As the Security Agent)
    Transactions
    • 13 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment of keyman insurance policies
    Créé le 28 févr. 2011
    Livré le 02 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and to the keyman insurance policies being policy no H253085401 r hardy £1,000,000 policy no H253083801 cd gowland £250,000 and policy no H253084601 ad sims £250,000 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 02 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 18 juin 2010
    Livré le 26 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 18 juin 2010
    Livré le 26 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee for itself and/or on behalf of each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 26 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 août 2008
    Livré le 12 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (For details of properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 août 2008
    Livré le 08 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of properties charged, please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Security Trustee)
    Transactions
    • 08 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Third supplemental legal charge
    Créé le 06 févr. 2008
    Livré le 25 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land on the south side of morson road enfield middlesex t/no AGL179913 all buildings and fixtures all proceeds of sale see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Second supplemental legal charge
    Créé le 06 févr. 2008
    Livré le 25 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land on the east side of morson road enfield middlesex t/no AGL169709 all buildings and fixtures all proceeds of sale.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 06 sept. 2007
    Livré le 15 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental legal charge
    Créé le 22 déc. 2006
    Livré le 08 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land at ponders end, enfield, middlesex t/nos MX341127, EGL307, NGL38431 and EGL307850 and all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assigment of key-man policies
    Créé le 13 nov. 2006
    Livré le 30 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns the policies being bupa policy insuring alan rankin policy number H223000201/CTV8/001. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of key-man policies
    Créé le 31 août 2004
    Livré le 21 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policies, all sums assured by it and all benefits which may arise under it and the assignors whole right title and interest in the policies. Insurer: st james' place, policy no:41C66W94, name of assured: charles dods, sum assured:£1,000,000; st james' place, 41C66T95, robert hardy, £1,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 31 août 2004
    Livré le 15 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 31 août 2004
    Livré le 11 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a shotton lane, cramlington, northumberland t/n ND27479 and l/h warehouse at south nelson industrial estate, cramlington, northumberland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (As Agent and Security Trustee for the Stockholders)
    Transactions
    • 11 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0