POULTER MARKETING GROUP LIMITED

POULTER MARKETING GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPOULTER MARKETING GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05188168
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de POULTER MARKETING GROUP LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe POULTER MARKETING GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Rose Wharf
    East Street
    LS9 8EE Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de POULTER MARKETING GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INHOCO 3106 LIMITED23 juil. 200423 juil. 2004

    Quels sont les derniers comptes de POULTER MARKETING GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour POULTER MARKETING GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    5 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 août 2011

    État du capital au 08 août 2011

    • Capital: GBP 939,938
    SH01

    legacy

    18 pagesMG01

    Nomination de Mr Trevor John O'reilly en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gary Knights en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    18 pagesMG01

    Cessation de la nomination de Mark Shaw en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Richard Timothy Barfield en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Richard Timothy Barfield en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Mark Shaw en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2009

    8 pagesAA

    legacy

    15 pagesMG01

    Cessation de la nomination de William Ronald en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de POULTER MARKETING GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARFIELD, Richard Timothy
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    157835390001
    BARFIELD, Richard Timothy
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish123477010001
    O'REILLY, Trevor John
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    Administrateur
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    IrelandIrish148130760001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Secrétaire
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    British129305300001
    LEACH, Ian
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    Secrétaire
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    British105115960001
    SAVAGE, Michael James
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British103609160001
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    British107353690001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BUCKLE, Mark Raymond
    Cherry Tree Cottage
    Mickley
    HG4 3JE Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Cherry Tree Cottage
    Mickley
    HG4 3JE Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish121880340001
    COLTON HAWKINS, Darren John
    5 Sheardale
    Honley
    HD9 6RU Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    5 Sheardale
    Honley
    HD9 6RU Huddersfield
    West Yorkshire
    British100773780001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Administrateur
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    EnglandBritish129305300001
    GORING, Nicholas Francis
    8 Holly Park
    Huby
    LS17 0BT Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 Holly Park
    Huby
    LS17 0BT Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish100773750001
    KNIGHTS, Gary
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    Administrateur
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    United KingdomBritish45695650002
    LEACH, Ian
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    Administrateur
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    United KingdomBritish105115960001
    MCCALL, Gary William
    Homestead Cottage Foxen Lane
    Mill Bank
    HX6 3EQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Administrateur
    Homestead Cottage Foxen Lane
    Mill Bank
    HX6 3EQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish59547330001
    RIVETT JONES, Peter
    12 High Street
    Spofforth
    HG3 1BQ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    12 High Street
    Spofforth
    HG3 1BQ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish112998390001
    RONALD, William David Gordon
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    Administrateur
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    EnglandBritish138299060001
    SAVAGE, Michael James
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Administrateur
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    EnglandBritish103609160001
    SAXBY, Mark Kenneth Baber
    Fairburns Farmhouse
    Wath
    HG4 5EJ Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Fairburns Farmhouse
    Wath
    HG4 5EJ Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritish59543920002
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    EnglandBritish107353690001
    TOYNTON, Peter Anthony
    Stable Court
    Picts Lane,
    RH13 8AW Cowfold
    West Sussex
    Administrateur
    Stable Court
    Picts Lane,
    RH13 8AW Cowfold
    West Sussex
    United KingdomBritish9723050002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001
    PEMBRIDGE PARTNERS LLP
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    Administrateur
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    85753460001

    POULTER MARKETING GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security confirmation and supplemental deed
    Créé le 13 juin 2011
    Livré le 17 juin 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transactions
    • 17 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    A security confirmation and supplemental deed
    Créé le 24 févr. 2011
    Livré le 08 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Charged by way of fixed charge all shares all related distribution rights all investment and all related distribution rights all book debts and all benefits rights and security held in respect of or to secure the payment of the book debts see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transactions
    • 08 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    A confirmatory deed
    Créé le 18 déc. 2009
    Livré le 04 janv. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 04 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    A confirmatory deed
    Créé le 31 juil. 2009
    Livré le 14 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Confirmatory deed supplemental to a debenture originally dated 19 august 2005 and
    Créé le 17 mars 2009
    Livré le 25 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 25 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed
    Créé le 20 mars 2008
    Livré le 10 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Security accession deed
    Créé le 15 sept. 2006
    Livré le 27 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustees for the Finance Parties
    Transactions
    • 27 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 04 oct. 2004
    Livré le 16 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the holders of the loan stock 2006 or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Murray Johnstone Limited (Security Trustee as Trustee for Each of the Holders of the Loan Stock)
    Transactions
    • 16 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 oct. 2004
    Livré le 12 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0