QUARTZ ACQUISITION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéQUARTZ ACQUISITION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05189492
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de QUARTZ ACQUISITION LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe QUARTZ ACQUISITION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Unit 2 Churchill Park
    Private Road No 2 Colwick
    NG4 2JR Nottingham
    Nottinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de QUARTZ ACQUISITION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour QUARTZ ACQUISITION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 051894920003 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Darren Hansel Lock en tant que directeur le 20 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Richard Thomas le 12 mars 2018

    2 pagesCH01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2017 au 31 déc. 2017

    3 pagesAA01

    Résolutions

    Resolutions
    40 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    1 pagesAA

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 02 oct. 2015

    13 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 02 oct. 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Qui sont les dirigeants de QUARTZ ACQUISITION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEWIS, David Mathew Aubrey
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian110226830001
    RISMAN, John Matthew
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish107350020002
    THOMAS, Andrew Richard
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritish154618250004
    DOBSON, Kevin Michael
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    Secrétaire
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    British95476170001
    NICHOLSON, James Brett
    351 Mapperley Plains
    Mapperley
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    351 Mapperley Plains
    Mapperley
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    British114457660001
    RUSSO, Lorenzo
    Flat 19
    17 Eccleston Place
    SW1W 9NF London
    Secrétaire
    Flat 19
    17 Eccleston Place
    SW1W 9NF London
    Italian96100220001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BURKE, David Richard Andrew
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    Administrateur
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    British61576180002
    DALBY, Simon Andrew
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish110227460002
    DOBSON, Kevin Michael
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    Administrateur
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    United KingdomBritish95476170001
    FERGUSON, Fiona Claire
    Cleveland Cottage
    Main Street
    NG23 5BA Claypole
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Cleveland Cottage
    Main Street
    NG23 5BA Claypole
    Nottinghamshire
    British55116100001
    HOLMES, Roger Anthony
    421 Flagstaff House
    10 St George Wharf
    SW8 2LZ Vauxhall London
    Administrateur
    421 Flagstaff House
    10 St George Wharf
    SW8 2LZ Vauxhall London
    United KingdomBritish105159350001
    LOCK, Darren Hansel
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131597650004
    NICHOLSON, James Brett
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    British99628210001
    PETROW, Steven
    Flat 2
    48 Lennox Gardens
    SW1X 0DJ London
    Administrateur
    Flat 2
    48 Lennox Gardens
    SW1X 0DJ London
    United KingdomAmerican96100200001
    RUSSO, Lorenzo
    Flat 19
    17 Eccleston Place
    SW1W 9NF London
    Administrateur
    Flat 19
    17 Eccleston Place
    SW1W 9NF London
    Italian96100220001
    SHANKS, Michael Anthony
    Oakdene
    Main Street
    NG25 0UT Morton
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Oakdene
    Main Street
    NG25 0UT Morton
    Nottinghamshire
    British25653690004
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur QUARTZ ACQUISITION LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Unit 2 Churchill Park
    England
    01 juil. 2016
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Unit 2 Churchill Park
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2692951
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    QUARTZ ACQUISITION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 août 2014
    Livré le 04 août 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ares Management Limited
    Transactions
    • 04 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 sept. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 21 juin 2007
    Livré le 02 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the group to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse, London Branch as Agent and Trustee for the Secured Creditors (Security Agent)
    Transactions
    • 02 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement
    Créé le 30 juil. 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the principal debtor to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0