ASCRIBE HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASCRIBE HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05204003
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fulford Grange Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ASCRIBE HOLDINGS PLC20 févr. 200920 févr. 2009
    ASCRIBE PLC25 nov. 200425 nov. 2004
    ASCRIBE LIMITED19 nov. 200419 nov. 2004
    EVER 2458 LIMITED12 août 200412 août 2004

    Quels sont les derniers comptes de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    État du capital au 10 oct. 2022

    • Capital: GBP 0.01
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 24/08/2022
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Capitalise £6190104 23/08/2022
    RES14

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 23/08/2022
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 23 août 2022

    • Capital: GBP 7,407,275.61
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 12 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA England à Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 pagesAD04

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 pagesAD04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Scroll Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2019

    2 pagesPSC05

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Rawdon House Green Lane Yeadon Leeds LS19 7BY à Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA le 02 déc. 2019

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BENSON, Christine
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Secrétaire
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    239348480001
    SOUTHBY, Peter John
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Administrateur
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    EnglandBritish116859780002
    STEWART, Paul
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Administrateur
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    EnglandBritish262072580001
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Secrétaire
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    192309700001
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    Secrétaire
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    British98814590001
    MOTTRAM, Mandy Joanne
    Constable Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BG Stockport
    18
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Constable Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BG Stockport
    18
    Cheshire
    England
    166860890001
    WAITE, Simon Nicholas
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    Secrétaire
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    213729210001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire désigné
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    BARBER, Dean Anthony
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    Administrateur
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    EnglandBritish230739040001
    CRITCHLOW, Anthony Stephen
    Grange Farm
    Grange Road Bromley Cross
    BL7 9AX Bolton
    Administrateur
    Grange Farm
    Grange Road Bromley Cross
    BL7 9AX Bolton
    EnglandBritish101716720002
    DICKSON, Christopher John
    Upton Grange
    Wonston
    SO21 3LR Winchester
    Administrateur
    Upton Grange
    Wonston
    SO21 3LR Winchester
    EnglandBritish100748280003
    HUGHES, David Michael
    Lea House
    Patshull Road, Albrighton
    WV7 3BH Wolverhampton
    Administrateur
    Lea House
    Patshull Road, Albrighton
    WV7 3BH Wolverhampton
    EnglandBritish12292930002
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    Administrateur
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    United KingdomBritish98814590001
    LEWIS, Graham Robert
    32 Ernest Road
    Wivenhoe
    CO7 9LQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    32 Ernest Road
    Wivenhoe
    CO7 9LQ Colchester
    Essex
    British117396680001
    MOORE, Christopher Edward
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish34428100003
    PRIESTNER, Ian
    Tirley Cottage
    Tirley Lane, Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Tirley Cottage
    Tirley Lane, Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish114678190001
    SPENCER, Christopher Michael Kennedy
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Administrateur
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish4742550002
    TAMBLYN, Christina
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Administrateur
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish191028210001
    TOWNEND, Nicholas Adam
    Ascribe House
    Branker Street Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    Administrateur
    Ascribe House
    Branker Street Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    EnglandBritish154577090001
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    British74738270002
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Administrateur désigné
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    06 avr. 2016
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06724468
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ASCRIBE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 01 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Eci Ventures Nominees Limited
    Transactions
    • 01 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 01 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage over stocks and shares by owner to secure own account
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 01 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The stocks shares and other marketable securities being 1 arkive computing limited (company number 4611493) ordinary, 292,886,176 ascribe limited (formerly known as asc computer software limited (company number 2394847) ordinary, 100 barwick systems limited (company number 1756830) ordinary see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of contracts
    Créé le 10 mai 2006
    Livré le 27 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights and powers under the contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 mars 2006
    Livré le 17 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0