ASCRIBE HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ASCRIBE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05204003 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
État du capital au 10 oct. 2022
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 23 août 2022
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA England à Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA | 1 pages | AD04 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA | 1 pages | AD04 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Scroll Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA | 1 pages | AD03 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Rawdon House Green Lane Yeadon Leeds LS19 7BY à Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA le 02 déc. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENSON, Christine | Secrétaire | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | 239348480001 | |||||||
| SOUTHBY, Peter John | Administrateur | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | England | British | 116859780002 | |||||
| STEWART, Paul | Administrateur | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | England | British | 262072580001 | |||||
| FARBRIDGE, Caroline Louise | Secrétaire | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | 192309700001 | |||||||
| LEE, Jeremy Stephen William | Secrétaire | 10 Hodge Fold SK14 6BL Broadbottom Cheshire | British | 98814590001 | ||||||
| MOTTRAM, Mandy Joanne | Secrétaire | Constable Drive Marple Bridge SK6 5BG Stockport 18 Cheshire England | 166860890001 | |||||||
| WAITE, Simon Nicholas | Secrétaire | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House | 213729210001 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Secrétaire désigné | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||
| BARBER, Dean Anthony | Administrateur | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House | England | British | 230739040001 | |||||
| CRITCHLOW, Anthony Stephen | Administrateur | Grange Farm Grange Road Bromley Cross BL7 9AX Bolton | England | British | 101716720002 | |||||
| DICKSON, Christopher John | Administrateur | Upton Grange Wonston SO21 3LR Winchester | England | British | 100748280003 | |||||
| HUGHES, David Michael | Administrateur | Lea House Patshull Road, Albrighton WV7 3BH Wolverhampton | England | British | 12292930002 | |||||
| LEE, Jeremy Stephen William | Administrateur | 10 Hodge Fold SK14 6BL Broadbottom Cheshire | United Kingdom | British | 98814590001 | |||||
| LEWIS, Graham Robert | Administrateur | 32 Ernest Road Wivenhoe CO7 9LQ Colchester Essex | British | 117396680001 | ||||||
| MOORE, Christopher Edward | Administrateur | Fanthill Hayway Lane Hook Norton OX15 5QJ Banbury Oxfordshire | England | British | 34428100003 | |||||
| PRIESTNER, Ian | Administrateur | Tirley Cottage Tirley Lane, Utkinton CW6 0JZ Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 114678190001 | |||||
| SPENCER, Christopher Michael Kennedy | Administrateur | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | 4742550002 | |||||
| TAMBLYN, Christina | Administrateur | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | 191028210001 | |||||
| TOWNEND, Nicholas Adam | Administrateur | Ascribe House Branker Street Westhoughton BL5 3JD Bolton | England | British | 154577090001 | |||||
| WOODBRIDGE, Mark Gavin | Administrateur | The Bungalow Marton CV23 9RS Rugby Warwickshire | British | 74738270002 | ||||||
| EVERDIRECTOR LIMITED | Administrateur désigné | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023520001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASCRIBE HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scroll Bidco Limited | 06 avr. 2016 | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
ASCRIBE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Créé le 26 mars 2009 Livré le 01 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 mars 2009 Livré le 01 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage over stocks and shares by owner to secure own account | Créé le 26 mars 2009 Livré le 01 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The stocks shares and other marketable securities being 1 arkive computing limited (company number 4611493) ordinary, 292,886,176 ascribe limited (formerly known as asc computer software limited (company number 2394847) ordinary, 100 barwick systems limited (company number 1756830) ordinary see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment of contracts | Créé le 10 mai 2006 Livré le 27 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the rights and powers under the contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 mars 2006 Livré le 17 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0