ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED

ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05206850
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance
    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ACRAMAN (378) LIMITED16 août 200416 août 2004

    Quels sont les derniers comptes de ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    15 pages4.72
    A3NLU46B

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 avr. 2014

    16 pages4.68
    A3A7M8MP

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    8 pages4.20
    A27Y7NTU

    Changement d'adresse du siège social de Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP United Kingdom le 09 mai 2013

    2 pagesAD01
    A2711LCH

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600
    A2711LCP

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2012

    État du capital au 20 août 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X1FQTEPE

    Changement d'adresse du siège social de The Barlands London Road Cheltenham Gloucestershire GL52 6UT le 23 juil. 2012

    1 pagesAD01
    X1DQTCG1

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    15 pagesAA
    A12QBJMN

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    XPTR8XHS

    Cessation de la nomination de William Carruthers en tant que directeur

    1 pagesTM01
    XO8P1UAN

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    15 pagesAA
    AS3VUQ6Q

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    X8VYUNAP

    Modification des coordonnées du secrétaire Tlt Secretaries Limited le 01 oct. 2009

    2 pagesCH04
    X8VYTNAO

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    17 pagesAA
    A3CFHFCC

    legacy

    4 pages363a
    X7XFGCW4

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    13 pagesAA
    A8Q7J6Z3

    legacy

    4 pages363a
    X26FJ4EL

    legacy

    1 pages190
    X26FI4EK

    legacy

    1 pages353
    X26FH4EJ

    legacy

    2 pages288a
    XO81D2PY

    legacy

    1 pages288b
    XO80I2P2

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TLT SECRETARIES LIMITED
    Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    One
    Secrétaire
    Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    One
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02754253
    77278550001
    FISHER, Robert, Dr
    White Cross House
    Winterbrook
    OX10 9ED Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    White Cross House
    Winterbrook
    OX10 9ED Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector116981620001
    WINNING, Christian Patrick Lorenzo
    Upper End Court
    Bretforton
    WR11 7GE Evesham
    7
    Worcestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Upper End Court
    Bretforton
    WR11 7GE Evesham
    7
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer132891370001
    MURPHY, Paul
    34 King Henry Close
    GL53 7EZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    34 King Henry Close
    GL53 7EZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector87441240001
    TLT SECRETARIES LIMITED
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Secrétaire
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    77278550001
    CARRUTHERS, William
    Lambourne House
    Cider Mill Orchard
    GL55 6QZ Weston-Sub-Edge
    Gloucestershire
    Administrateur
    Lambourne House
    Cider Mill Orchard
    GL55 6QZ Weston-Sub-Edge
    Gloucestershire
    United KingdomBritishOperations Director72325990001
    DICK, Callum Andrew John
    9 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Administrateur
    9 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    EnglandBritishDirector118924270001
    DOST, Parminder Pal Singh
    8 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    8 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishDirector87287360001
    MURPHY, Paul
    34 King Henry Close
    GL53 7EZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    34 King Henry Close
    GL53 7EZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector87441240001
    TLT DIRECTORS LIMITED
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Administrateur
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    77278540002

    ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 03 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and alan dick & company (holdings) limited and certain group companies on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of charge all of the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (As Security Trustee on Trust for the Other Financeparties)
    Transactions
    • 03 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 24 août 2006
    Livré le 31 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transactions
    • 31 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Share pledge agreement
    Créé le 24 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties
    Brèves mentions
    The pledgor agreed to pledge the pledged shares in the company to the security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 juin 2005
    Livré le 30 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 30 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 juin 2005
    Livré le 24 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and each of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Security Trustee for Each of the Finance Parties) (Thesecurity Trustee)
    Transactions
    • 24 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)

    ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 avr. 2013Commencement of winding up
    08 avr. 2015Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Stewart Wood
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YC London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YC London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0