ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05206850 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O GRANT THORNTON UK LLP 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2011 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 15 pages | 4.72 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 avr. 2014 | 16 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché | 8 pages | 4.20 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP United Kingdom le 09 mai 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Barlands London Road Cheltenham Gloucestershire GL52 6UT le 23 juil. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2011 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Carruthers en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2010 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Tlt Secretaries Limited le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2009 | 17 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2008 | 13 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2007 | 10 pages | AA |
Qui sont les dirigeants de ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Redcliff Street BS1 6TP Bristol One |
| 77278550001 | ||||||||||
FISHER, Robert, Dr | Administrateur | White Cross House Winterbrook OX10 9ED Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 116981620001 | ||||||||
WINNING, Christian Patrick Lorenzo | Administrateur | Upper End Court Bretforton WR11 7GE Evesham 7 Worcestershire United Kingdom | England | British | Chief Financial Officer | 132891370001 | ||||||||
MURPHY, Paul | Secrétaire | 34 King Henry Close GL53 7EZ Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 87441240001 | |||||||||
TLT SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | One Redcliff Street BS1 6TP Bristol | 77278550001 | |||||||||||
CARRUTHERS, William | Administrateur | Lambourne House Cider Mill Orchard GL55 6QZ Weston-Sub-Edge Gloucestershire | United Kingdom | British | Operations Director | 72325990001 | ||||||||
DICK, Callum Andrew John | Administrateur | 9 Charlton Park Gate GL53 7DJ Cheltenham | England | British | Director | 118924270001 | ||||||||
DOST, Parminder Pal Singh | Administrateur | 8 Halland Way HA6 2AG Northwood Middlesex | England | British | Director | 87287360001 | ||||||||
MURPHY, Paul | Administrateur | 34 King Henry Close GL53 7EZ Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 87441240001 | |||||||||
TLT DIRECTORS LIMITED | Administrateur | One Redcliff Street BS1 6TP Bristol | 77278540002 |
ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge | Créé le 16 oct. 2006 Livré le 03 nov. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and alan dick & company (holdings) limited and certain group companies on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of charge all of the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 24 août 2006 Livré le 31 août 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Share pledge agreement | Créé le 24 juil. 2006 Livré le 01 août 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the finance parties | |
Brèves mentions The pledgor agreed to pledge the pledged shares in the company to the security trustee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 13 juin 2005 Livré le 30 juin 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 13 juin 2005 Livré le 24 juin 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee and each of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
ALANDICK MIDDLE EAST (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0