SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED

SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05210945
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?

    • Établissements de soins infirmiers en résidence (87100) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERCEDE 1963 LIMITED20 août 200420 août 2004

    Quels sont les derniers comptes de SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 juin 2019

    15 pagesLIQ03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 11 Old Jewry London EC2R 8DU

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 11 Old Jewry London EC2R 8DU

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 2nd Floor 11 Old Jewry London EC2R 8DU à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 25 juil. 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 juin 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    8 pagesLIQ01

    legacy

    4 pagesSH20

    État du capital au 26 juin 2018

    • Capital: GBP 1.00
    5 pagesSH19

    legacy

    4 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account reduced 26/06/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mr John Anthony Goodey en tant qu'administrateur le 21 juin 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Justin Reynolds Skiver en tant qu'administrateur le 01 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Anthony Goodey en tant que directeur le 01 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 20 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2016 au 30 juin 2017

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées du secrétaire Bedell Trust Uk Limited le 15 nov. 2016

    1 pagesCH04

    Déclaration de confirmation établie le 20 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    25 pagesAA

    Cessation de la nomination de Keith Russell Crockett en tant que directeur le 30 juin 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Anthony Goodey en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Caroline Mary Roberts en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Justin Skiver en tant que directeur le 01 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OCORIAN (UK) LIMITED
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    England
    Secrétaire
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5534412
    113583560003
    GOODEY, John Anthony
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritish207171280001
    ROBERTS, Caroline Mary
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandAmerican206974150001
    SKIVER, Justin Reynolds
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United StatesAmerican241791140001
    MILLIKEN, Alistair
    34 Elwill Way
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    34 Elwill Way
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    British74424700001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    c/o Nabarro Llp
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon House
    England
    Secrétaire
    c/o Nabarro Llp
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2231995
    67339580001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    STATE STREET SECRETARIES (UK) LIMITED
    Floor, Phoenix House 18 King William Street
    EC4N 7BP London
    1st
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor, Phoenix House 18 King William Street
    EC4N 7BP London
    1st
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3691921
    108845150006
    ADAMS, Carl George
    4746 Holly Ave
    IRISH Fairfax
    Virginia 22030
    Usa
    Administrateur
    4746 Holly Ave
    IRISH Fairfax
    Virginia 22030
    Usa
    American123180810001
    CASH, Mark John
    Woes Cottage
    Church Street
    RH12 3EA Rudgwick
    West Sussex
    Administrateur
    Woes Cottage
    Church Street
    RH12 3EA Rudgwick
    West Sussex
    EnglandBritish142633680001
    CRABTREE, Michael Andrew
    House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon
    United Kingdom
    UsaUs Citizen175436800001
    CROCKETT, Keith Russell
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    England
    Administrateur
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    England
    EnglandBritish179532870001
    DRYDEN, Rachel
    Elmthorpe Road
    Wolvercote
    OX2 8PA Oxford
    42
    Administrateur
    Elmthorpe Road
    Wolvercote
    OX2 8PA Oxford
    42
    EnglandBritish137848010005
    GOODEY, John Anthony
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    Administrateur
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    EnglandBritish207171280001
    HARNED, Peter Clarke
    Melville Road
    SW13 9RH London
    49
    United Kingdom
    Administrateur
    Melville Road
    SW13 9RH London
    49
    United Kingdom
    United KingdomAmerican125065690002
    HARPER, Jonathan Mark
    10 Penn Road
    HP9 2PW Beaconsfield
    Sunrise Senior Living Suite C
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    10 Penn Road
    HP9 2PW Beaconsfield
    Sunrise Senior Living Suite C
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish166169730001
    HARPER, Jonathan Mark
    16 Warwick Road
    HP9 2PE Beaconsfield
    Crofton House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Warwick Road
    HP9 2PE Beaconsfield
    Crofton House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish166169730001
    IBELE, Erin Carol
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    England
    Administrateur
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    England
    United StatesAmerican175667430001
    JONES, James Rufus
    Floor, Phoenix House 18 King William Street
    EC4N 7BP London
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor, Phoenix House 18 King William Street
    EC4N 7BP London
    1st
    United Kingdom
    United KingdomUs Citizen139882360001
    KEINAN, Tuvi
    3 Nutley Terrace
    NW3 5BX London
    Administrateur
    3 Nutley Terrace
    NW3 5BX London
    United KingdomBritish80469170002
    LOCKYER, David
    26 Margaret Avenue
    Shenfield
    CM15 8RF Brentwood
    Essex
    Administrateur
    26 Margaret Avenue
    Shenfield
    CM15 8RF Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish110715790001
    MILLER, Jeffrey Herman
    House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon
    United Kingdom
    UsaAmerican175667420001
    MILSTEIN, Paul Scott
    10916 Blue Roan Road
    IRISH Oakton
    Virginia 22124
    Usa
    Administrateur
    10916 Blue Roan Road
    IRISH Oakton
    Virginia 22124
    Usa
    UsaUnited States142614120001
    NEWELL, Thomas Bruce
    1604 Montmorency Drive
    Vienna
    Virginia 22182
    Usa
    Administrateur
    1604 Montmorency Drive
    Vienna
    Virginia 22182
    Usa
    American75292770001
    RAPLEY, Vincent Michael
    Floor, Phoenix House 18 King William Street
    EC4N 7BP London
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor, Phoenix House 18 King William Street
    EC4N 7BP London
    1st
    United Kingdom
    EnglandBritish97416440001
    RUSH, Bradley Burnett
    371 Church St. Ne
    IRISH Vienna
    Virginia 22180
    Usa
    Administrateur
    371 Church St. Ne
    IRISH Vienna
    Virginia 22180
    Usa
    American114799100001
    SCALLY, Steven Antony
    House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon
    United Kingdom
    United KingdomBritish129486460001
    SKIVER, Justin
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    England
    Administrateur
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    England
    Ohio, UsaAmerican182743080001
    TOMASSO, Tiffany Lynn
    12834 Parapet Way
    IRISH Oak Hill
    Virginia Va 20171
    Usa
    Administrateur
    12834 Parapet Way
    IRISH Oak Hill
    Virginia Va 20171
    Usa
    American90046730001
    VANDEN HENDE, Thierry
    1 Roland Gardens
    South Kensington
    SW7 3PE London
    Flat 1
    Administrateur
    1 Roland Gardens
    South Kensington
    SW7 3PE London
    Flat 1
    United KingdomBelgian136473570001
    WEBSTER, Simon Lee
    Broad Reach
    Warren Row
    RG10 8QL Wargrave
    Berkshire
    Administrateur
    Broad Reach
    Warren Row
    RG10 8QL Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritish108124730001
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Administrateur désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Administrateur désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900027570001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Old Jewry
    2nd Floor
    EC2R 8DU London
    11
    England
    06 avr. 2016
    Old Jewry
    2nd Floor
    EC2R 8DU London
    11
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleGbr
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06300259
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 16 oct. 2012
    Livré le 26 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (Uplift Participant)
    Transactions
    • 26 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental charge
    Créé le 14 déc. 2007
    Livré le 21 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor and the msref vi fund to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The additional property: the leases over the premises known as the former bassett hotel 111 burgess road southampton t/n HP682404, the lodge 5 church road edgbaston birmingham t/n WM877121, land on the west side of copsem lane esher surrey t/n SY752760, for details of further property charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transactions
    • 21 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Opco debenture
    Créé le 20 août 2007
    Livré le 22 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to BECOME3 due from each obligor and the msref vi fund to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("the Security Trustee")
    Transactions
    • 22 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 29 sept. 2004
    Livré le 06 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee, the arranger, the agent and the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 16-18 poole road westbo. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.a/N.V (The Security Trustee)
    Transactions
    • 06 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 juin 2018Commencement of winding up
    07 oct. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    practitioner
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Ian Harvey Dean
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    practitioner
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0