SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05210945 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 juin 2019 | 15 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 11 Old Jewry London EC2R 8DU | 2 pages | AD03 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 11 Old Jewry London EC2R 8DU | 2 pages | AD02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2nd Floor 11 Old Jewry London EC2R 8DU à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 25 juil. 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 8 pages | LIQ01 | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 26 juin 2018
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mr John Anthony Goodey en tant qu'administrateur le 21 juin 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Justin Reynolds Skiver en tant qu'administrateur le 01 janv. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de John Anthony Goodey en tant que directeur le 01 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 août 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2016 au 30 juin 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Bedell Trust Uk Limited le 15 nov. 2016 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 août 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 25 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Keith Russell Crockett en tant que directeur le 30 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr John Anthony Goodey en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mrs Caroline Mary Roberts en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Justin Skiver en tant que directeur le 01 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCORIAN (UK) LIMITED | Secrétaire | 11 Old Jewry EC2R 8DU London 2nd Floor England |
| 113583560003 | ||||||||||
| GOODEY, John Anthony | Administrateur | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | British | 207171280001 | |||||||||
| ROBERTS, Caroline Mary | Administrateur | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | American | 206974150001 | |||||||||
| SKIVER, Justin Reynolds | Administrateur | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United States | American | 241791140001 | |||||||||
| MILLIKEN, Alistair | Secrétaire | 34 Elwill Way BR3 3AD Beckenham Kent | British | 74424700001 | ||||||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | c/o Nabarro Llp 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon House England |
| 67339580001 | ||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||||||
| STATE STREET SECRETARIES (UK) LIMITED | Secrétaire | Floor, Phoenix House 18 King William Street EC4N 7BP London 1st United Kingdom |
| 108845150006 | ||||||||||
| ADAMS, Carl George | Administrateur | 4746 Holly Ave IRISH Fairfax Virginia 22030 Usa | American | 123180810001 | ||||||||||
| CASH, Mark John | Administrateur | Woes Cottage Church Street RH12 3EA Rudgwick West Sussex | England | British | 142633680001 | |||||||||
| CRABTREE, Michael Andrew | Administrateur | House 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon United Kingdom | Usa | Us Citizen | 175436800001 | |||||||||
| CROCKETT, Keith Russell | Administrateur | 11 Old Jewry EC2R 8DU London 2nd Floor England | England | British | 179532870001 | |||||||||
| DRYDEN, Rachel | Administrateur | Elmthorpe Road Wolvercote OX2 8PA Oxford 42 | England | British | 137848010005 | |||||||||
| GOODEY, John Anthony | Administrateur | 11 Old Jewry EC2R 8DU London 2nd Floor | England | British | 207171280001 | |||||||||
| HARNED, Peter Clarke | Administrateur | Melville Road SW13 9RH London 49 United Kingdom | United Kingdom | American | 125065690002 | |||||||||
| HARPER, Jonathan Mark | Administrateur | 10 Penn Road HP9 2PW Beaconsfield Sunrise Senior Living Suite C Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 166169730001 | |||||||||
| HARPER, Jonathan Mark | Administrateur | 16 Warwick Road HP9 2PE Beaconsfield Crofton House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 166169730001 | |||||||||
| IBELE, Erin Carol | Administrateur | 11 Old Jewry EC2R 8DU London 2nd Floor England | United States | American | 175667430001 | |||||||||
| JONES, James Rufus | Administrateur | Floor, Phoenix House 18 King William Street EC4N 7BP London 1st United Kingdom | United Kingdom | Us Citizen | 139882360001 | |||||||||
| KEINAN, Tuvi | Administrateur | 3 Nutley Terrace NW3 5BX London | United Kingdom | British | 80469170002 | |||||||||
| LOCKYER, David | Administrateur | 26 Margaret Avenue Shenfield CM15 8RF Brentwood Essex | United Kingdom | British | 110715790001 | |||||||||
| MILLER, Jeffrey Herman | Administrateur | House 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon United Kingdom | Usa | American | 175667420001 | |||||||||
| MILSTEIN, Paul Scott | Administrateur | 10916 Blue Roan Road IRISH Oakton Virginia 22124 Usa | Usa | United States | 142614120001 | |||||||||
| NEWELL, Thomas Bruce | Administrateur | 1604 Montmorency Drive Vienna Virginia 22182 Usa | American | 75292770001 | ||||||||||
| RAPLEY, Vincent Michael | Administrateur | Floor, Phoenix House 18 King William Street EC4N 7BP London 1st United Kingdom | England | British | 97416440001 | |||||||||
| RUSH, Bradley Burnett | Administrateur | 371 Church St. Ne IRISH Vienna Virginia 22180 Usa | American | 114799100001 | ||||||||||
| SCALLY, Steven Antony | Administrateur | House 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon United Kingdom | United Kingdom | British | 129486460001 | |||||||||
| SKIVER, Justin | Administrateur | 11 Old Jewry EC2R 8DU London 2nd Floor England | Ohio, Usa | American | 182743080001 | |||||||||
| TOMASSO, Tiffany Lynn | Administrateur | 12834 Parapet Way IRISH Oak Hill Virginia Va 20171 Usa | American | 90046730001 | ||||||||||
| VANDEN HENDE, Thierry | Administrateur | 1 Roland Gardens South Kensington SW7 3PE London Flat 1 | United Kingdom | Belgian | 136473570001 | |||||||||
| WEBSTER, Simon Lee | Administrateur | Broad Reach Warren Row RG10 8QL Wargrave Berkshire | England | British | 108124730001 | |||||||||
| MITRE DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900024450001 | |||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900027570001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn Opco Limited | 06 avr. 2016 | Old Jewry 2nd Floor EC2R 8DU London 11 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 16 oct. 2012 Livré le 26 oct. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental charge | Créé le 14 déc. 2007 Livré le 21 déc. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor and the msref vi fund to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The additional property: the leases over the premises known as the former bassett hotel 111 burgess road southampton t/n HP682404, the lodge 5 church road edgbaston birmingham t/n WM877121, land on the west side of copsem lane esher surrey t/n SY752760, for details of further property charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Opco debenture | Créé le 20 août 2007 Livré le 22 août 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to BECOME3 due from each obligor and the msref vi fund to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 29 sept. 2004 Livré le 06 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee, the arranger, the agent and the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/H property k/a 16-18 poole road westbo. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
SUNRISE OPERATIONS WESTBOURNE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0