B.I.B.U. ACQUISITIONS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | B.I.B.U. ACQUISITIONS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Détails du statut de la société | Proposition active de radiation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05216169 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe B.I.B.U. ACQUISITIONS LIMITED ?
Adresse du siège social | 2 Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de B.I.B.U. ACQUISITIONS LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour B.I.B.U. ACQUISITIONS LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 29 nov. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 13 déc. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 29 nov. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour B.I.B.U. ACQUISITIONS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Antonios Erotocritou en tant qu'administrateur le 16 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 21 pages | AA | ||
legacy | 205 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Cessation de la nomination de Derek John Coles en tant que directeur le 01 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 6 pages | AA | ||
Nomination de Ms Diane Cougill en tant qu'administrateur le 11 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jonathan Guy Sutton en tant que directeur le 11 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Mr Jonathan Guy Sutton en tant qu'administrateur le 27 janv. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Ardonagh Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 27 janv. 2022 | 2 pages | AP04 | ||
Cessation de la nomination de Dean Clarke en tant que secrétaire le 27 janv. 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Scott William Hough en tant que directeur le 27 janv. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Cessation de Cullum Capital Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 déc. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||
Notification de Geo Specialty Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 déc. 2018 | 2 pages | PSC02 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Scott William Hough le 12 oct. 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Qui sont les dirigeants de B.I.B.U. ACQUISITIONS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom |
| 288842300001 | ||||||||||
COUGILL, Diane | Administrateur | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | England | British | Chief Finance Officer | 158614590002 | ||||||||
EROTOCRITOU, Antonios | Administrateur | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | United Kingdom | Cypriot | Group Finance Director | 277780910001 | ||||||||
BROWN, Ian William | Secrétaire | 36 Beech Wood Drive Tonyrefail CF39 8JE Rhondda Cynon Taff Mid Glamorgan | British | Director | 262382040001 | |||||||||
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Secrétaire | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | British | 117669700002 | ||||||||||
CLARKE, Dean | Secrétaire | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | 253940500001 | |||||||||||
GOURIET, Geoffrey Costerton | Secrétaire | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | 249428400001 | |||||||||||
GREGORY, Jacqueline Anne | Secrétaire | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | 221980740001 | |||||||||||
OWENS, Jennifer | Secrétaire | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | 183283510001 | |||||||||||
RAGAN, Sharon Marie | Secrétaire | Old Tregyrnog Farmhouse St Brides Super Ely CF5 6EZ Cardiff | British | Company Secretary | 67745500003 | |||||||||
THIRD PARTY COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Unit 10 Robjohns House Navigation Road CM2 6ND Chelmsford Essex | 94576040001 | |||||||||||
BARR, Graham Maxwell | Administrateur | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 125097020001 | ||||||||
BROWN, Ian William | Administrateur | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | United Kingdom | British | Director | 262382040001 | ||||||||
BROWN, Roger Michael | Administrateur | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | British | Company Director | 134140540001 | ||||||||
BRUCE, David James | Administrateur | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 171398800001 | ||||||||
CHARD, Michael Francis | Administrateur | 23 Knightsbridge Court CH1 1QG Chester | Uk | British | Chairman | 45725420009 | ||||||||
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Administrateur | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | Legal Counsel | 149939610001 | ||||||||
COLES, Derek John | Administrateur | Lakeside Boulevard DN4 5PL Doncaster Quay Point South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 183213790001 | ||||||||
EGAN, Scott | Administrateur | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | Director | 170703910001 | ||||||||
EROTOCRITOU, Antonios | Administrateur | Minster Court EC3R 7AA London 1 United Kingdom | United Kingdom | Cypriot | Deputy Cfo | 167795710001 | ||||||||
HAGGETT, Linda | Administrateur | 51 Graig Y Mynydd Thomastown, Tonyrefail CF39 8FD Porth Mid Glamorgan | British | Chief Operating Officer | 107657520001 | |||||||||
HODGES, Mark Steven | Administrateur | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 58444370003 | ||||||||
HOUGH, Scott William | Administrateur | Lakeside Boulevard DN4 5PL Doncaster Quay Point South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 85495940006 | ||||||||
JOHNSON, Timothy David | Administrateur | The Green Westerham TN16 1AS Kent Nursery Cottage 3a | England | British | Company Director | 129538180001 | ||||||||
MUGGE, Mark Stephen | Administrateur | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | England | British | Director | 162920630005 | ||||||||
PARK, Bryan | Administrateur | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | Director | 113694470002 | ||||||||
RAGAN, Paul Robert | Administrateur | Tregyrnog Farmhouse St. Brides-Super-Ely CF5 6EZ Cardiff Vale Of Glamorgan | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 60263070005 | ||||||||
REA, Michael Peter | Administrateur | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | Director | 147194830001 | ||||||||
ROSS, David Christopher | Administrateur | Minster Court EC3R 7AA London 1 United Kingdom | England | Irish | Director | 222326970001 | ||||||||
SUTTON, Jonathan Guy, Mr | Administrateur | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | England | British | Finance Director | 292196320001 | ||||||||
THIRD PARTY FORMATIONS LIMITED | Administrateur | Unit 10 Robjohns House Navigation Road CM2 6ND Chelmsford Essex | 99229970001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur B.I.B.U. ACQUISITIONS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geo Specialty Group Holdings Limited | 24 déc. 2018 | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Cullum Capital Ventures Limited | 06 avr. 2016 | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0