CBRAIL (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCBRAIL (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05220750
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CBRAIL (UK) LIMITED ?

    • (6521) /

    Où se situe CBRAIL (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CBRAIL (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CB RAIL (UK) LIMITED02 sept. 200402 sept. 2004

    Quels sont les derniers comptes de CBRAIL (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CBRAIL (UK) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CBRAIL (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2014

    7 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2013

    7 pages4.68

    Nomination de Mr Colin Graham Dowsett en tant qu'administrateur le 02 janv. 2013

    3 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Level 7 Bishopgate Exchnge 155 Bishopsgate London EC2M 3YB le 05 avr. 2012

    2 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Gavin White le 07 mars 2012

    1 pagesCH03

    Nomination de Mr Gavin White en tant que secrétaire le 09 déc. 2011

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Paul Gittins en tant que secrétaire le 09 déc. 2011

    1 pagesTM02

    legacy

    5 pagesMG02

    legacy

    5 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 sept. 2011

    État du capital au 05 sept. 2011

    • Capital: EUR 500
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Neil Lewis en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de David Shindler en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Timothy Sebastian Durham en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Paul Gittins le 05 juil. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Paul Gittins le 10 mai 2010

    1 pagesCH03

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de CBRAIL (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WHITE, Gavin Raymond
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    165229210001
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant152332230001
    DURHAM, Timothy Sebastian
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritishHead Of Rail Capital152682880001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    British32609030001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritishBanker96202910001
    DUNCAN, Timothy
    Ellerslie House
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    Administrateur
    Ellerslie House
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritishLawyer104005710001
    GOOSEN, Willem
    Vogelsangstrasse 6
    Grunwald
    82031
    Germany
    Administrateur
    Vogelsangstrasse 6
    Grunwald
    82031
    Germany
    DutchCommercial Director104881570002
    LEWIS, Neil Dewar
    15th Floor
    5 Aldermanbury Square
    EC2V 7HR London
    Babcock & Brown International Group
    Administrateur
    15th Floor
    5 Aldermanbury Square
    EC2V 7HR London
    Babcock & Brown International Group
    EnglandBritishLawyer/Director103229440001
    MARR, Graham Peter Wilson
    Mole Rise
    15 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Mole Rise
    15 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    EnglandBritishBanker69564800002
    MORE, Gordon Lennie Truman
    20 Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollar
    Clackmannanshire
    Administrateur
    20 Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollar
    Clackmannanshire
    United KingdomScottishBanker111414890002
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    BritishFinancial Controller56296720007
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    BritishFinancial Controller56296720007
    REID, George Gibson
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    BritishAccountant95498730001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant92235400001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant92235400001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishHead Of Structured Asset Finan64287260001
    WALSH, Kenton
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishBanker125918020001
    WILSON, Edward Arthur
    Flat 3 28 Folgate Street
    E1 6BX London
    Administrateur
    Flat 3 28 Folgate Street
    E1 6BX London
    United KingdomBritishBanker214718430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CBRAIL (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 mars 2006
    Livré le 06 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited Acting as Security Trustee for and on Behalfime
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited Acting as Security Trustee for and on Behalfof the Bank and Any Other Lenders from Time to T
    Transactions
    • 06 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 14 janv. 2005
    Livré le 28 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets and equipment present and future including goodwill bookdebts and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and and on Behalf Ofthe Bank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transactions
    • 28 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    CBRAIL (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 déc. 2014Dissolved on
    28 mars 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0