NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED

NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05234591
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC3P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NORMANTRAIL LIMITED17 sept. 200417 sept. 2004

    Quels sont les derniers comptes de NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Changement d'adresse du siège social de Level 20 25 Canada Square London E14 5LQ à 30 Finsbury Square London EC3P 2YU le 07 juin 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 mai 2018

    LRESSP

    Nomination de Mr Kazushige Katamura en tant qu'administrateur le 25 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Hiromu Kayamori en tant que directeur le 25 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Isao Kajimura en tant qu'administrateur le 15 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ro Okaniwa en tant que directeur le 15 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Hiromu Kayamori en tant qu'administrateur le 16 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Shigeaki Ihara en tant que directeur le 16 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    23 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 19 sept. 2017

    • Capital: USD 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account 19/09/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Sarah Jane Gregory en tant que secrétaire le 01 juin 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Roger Derek Simpson en tant que secrétaire le 31 mai 2017

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Hillary Sue Berger en tant que secrétaire le 18 févr. 2016

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 oct. 2015

    État du capital au 01 oct. 2015

    • Capital: USD 218,380
    SH01

    Qui sont les dirigeants de NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GREGORY, Sarah Jane
    Finsbury Square
    EC3P 2YU London
    30
    Secrétaire
    Finsbury Square
    EC3P 2YU London
    30
    232752890001
    ALCOCK, David George
    Lakeside Business Village
    St David's Park
    Deeside
    Bala House
    Flintshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lakeside Business Village
    St David's Park
    Deeside
    Bala House
    Flintshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish122889210001
    GARNER, Andrew Wilson
    Finsbury Square
    EC3P 2YU London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC3P 2YU London
    30
    WalesBritish187224770001
    KAJIMURA, Isao
    Finsbury Square
    EC3P 2YU London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC3P 2YU London
    30
    JapanJapanese231316540001
    KATAMURA, Kazushige
    1 St. Martin's Le Grand
    EC1A 4AS London
    8th & 9th Floors
    England
    Administrateur
    1 St. Martin's Le Grand
    EC1A 4AS London
    8th & 9th Floors
    England
    EnglandJapanese194604460001
    BERGER, Hillary Sue
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    Secrétaire
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    166478290001
    RAMSAY, Andrew Stephen James, Mr.
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    Secrétaire
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    British76376410014
    SIMPSON, Roger Derek
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    Secrétaire
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    British158511790001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BAKER, Michael Stuart
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    Administrateur
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    United KingdomBritish158547860001
    BARLOW, Peter George
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    Administrateur
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    United KingdomBritish77277970003
    DRAPPER, Steven, Mr.
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    Administrateur
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    United KingdomBritish294640700001
    FURUKAWA, Masaaki
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    Administrateur
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    UkJapanese136026050001
    GRIFFITHS, Gareth Neil
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    Administrateur
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    United KingdomBritish102373720001
    ICHIKAWA, Makoto
    Flat 15 The Visage Apartments
    Winchester Road
    NW3 3NW London
    Administrateur
    Flat 15 The Visage Apartments
    Winchester Road
    NW3 3NW London
    Japanese102014380002
    IHARA, Shigeaki
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    Administrateur
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    UkJapanese199197270001
    KAJIMURA, Isao, Dr
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    Administrateur
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    United KingdomJapanese162880070003
    KAYAMORI, Hiromu
    Marunouchi 1 Chome
    Chiyoda-Ku
    Tokyo 100-8631
    1-3
    Japan
    Administrateur
    Marunouchi 1 Chome
    Chiyoda-Ku
    Tokyo 100-8631
    1-3
    Japan
    JapaneseJapanese232828850001
    KOGA, Hiroyuki
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    Administrateur
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    United KingdomJapanese158633860001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish147682410001
    MOORE, Antony Dennis
    49 Bonners Close
    Reeds Farm
    SN16 9UF Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    49 Bonners Close
    Reeds Farm
    SN16 9UF Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish100708700001
    OKANIWA, Ro
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    Administrateur
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    EnglandJapanese189843910002
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Administrateur désigné
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    RAMSAY, Andrew Stephen James, Mr.
    Stable Barn Chilswell Farm
    Chilswell Lane
    OX1 5EP Boars Hill
    Oxfordshire
    Administrateur
    Stable Barn Chilswell Farm
    Chilswell Lane
    OX1 5EP Boars Hill
    Oxfordshire
    EnglandBritish76376410014
    RILEY, Stephen, Dr
    Churdles
    Farm Lane
    KT21 1HP Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    Churdles
    Farm Lane
    KT21 1HP Ashtead
    Surrey
    EnglandBritish94736490005
    SMALL, Penelope Louise
    The Oaks
    Dodds Lane
    HP8 4EL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Oaks
    Dodds Lane
    HP8 4EL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92394710005
    SMITH, Sarah Louise
    Lakeside Business Village
    St David's Park
    CH5 3XJ Deeside
    Bala House
    Flintshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lakeside Business Village
    St David's Park
    CH5 3XJ Deeside
    Bala House
    Flintshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170927440001
    SUGIZAKI, Masashi
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    Administrateur
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    United KingdomJapanese157644370001
    TAKASHI, Toru
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    Administrateur
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4DP London
    Senator House
    United KingdomJapanese132426440003
    UMEZU, Takashi
    Boundary Road
    NW8 6NT London
    Flat 71 Blair Court
    Administrateur
    Boundary Road
    NW8 6NT London
    Flat 71 Blair Court
    British137170430001
    WILLIAMSON, Mark David
    The Old Coach House
    Wierton Hill
    ME17 4JS Boughton Monchelsea
    Kent
    Administrateur
    The Old Coach House
    Wierton Hill
    ME17 4JS Boughton Monchelsea
    Kent
    British50785820002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ipm Holdings (Uk) Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    06 avr. 2016
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 20
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement09022986
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Share charge
    Créé le 28 juil. 2005
    Livré le 03 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All present and future shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 03 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security of assignment of agreements
    Créé le 28 juil. 2005
    Livré le 03 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from saltend cogeneration company limited to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 03 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 déc. 2004
    Livré le 10 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to beomce due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge, all rights which it may have now or subsequently in respect of any book debts, by way of first fixed charge all of the amounts standing to the credit, from time to time, of any of its banks accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V. (As Security Trustee)
    Transactions
    • 10 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NORMANTRAIL (UK CO 3) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 mai 2018Commencement of winding up
    13 juin 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0