PRAX UPSTREAM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPRAX UPSTREAM LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05245689
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PRAX UPSTREAM LIMITED ?

    • Extraction de pétrole brut (06100) / Exploitation de mines et carrières
    • Extraction de gaz naturel (06200) / Exploitation de mines et carrières

    Où se situe PRAX UPSTREAM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4th Floor 72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    Greater London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PRAX UPSTREAM LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HURRICANE ENERGY LIMITED22 juin 202322 juin 2023
    HURRICANE ENERGY PLC17 avr. 201317 avr. 2013
    HURRICANE EXPLORATION PLC24 févr. 200524 févr. 2005
    HURRICANE EXPLORATION LIMITED22 déc. 200422 déc. 2004
    BLAKEDEW 531 LIMITED29 sept. 200429 sept. 2004

    Quels sont les derniers comptes de PRAX UPSTREAM LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le28 févr. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes28 févr. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PRAX UPSTREAM LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au29 sept. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation13 oct. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au29 sept. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour PRAX UPSTREAM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Inscription de la charge 052456890008, créée le 12 févr. 2026

    35 pagesMR01

    Inscription de la charge 052456890007, créée le 22 déc. 2025

    35 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Elemental Company Secretarial Limited en tant que secrétaire le 11 déc. 2025

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Nicholas John Pike en tant que directeur le 11 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alessandro Agostini en tant que directeur le 11 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Amba Secretaries Limited en tant que secrétaire le 11 déc. 2025

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Iain Charles Mckendrick en tant que directeur le 11 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen David Lambert en tant qu'administrateur le 11 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Daniel Charles Fewkes en tant qu'administrateur le 11 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 4th Floor 72 Welbeck Street Paddington Central, Kingdom Street London Greater London W1G 0AY United Kingdom à 4th Floor 72 Welbeck Street London Greater London W1G 0AY le 11 déc. 2025

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Michael Paul Killeen en tant qu'administrateur le 11 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Christopher Martin Cox en tant qu'administrateur le 11 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Martin Francis David Copeland en tant qu'administrateur le 11 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Harvest House Horizon Business Village 1 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TJ United Kingdom à 4th Floor 72 Welbeck Street Paddington Central, Kingdom Street London Greater London W1G 0AY le 11 déc. 2025

    1 pagesAD01

    replacement-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date

    3 pagesRP01CS01

    Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas John Pike le 22 juil. 2025

    2 pagesCH01

    Nomination de Nicholas John Pike en tant qu'administrateur le 06 juil. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Winston Sanjeevkumar Soosaipillai en tant que directeur le 04 juil. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 29 févr. 2024

    60 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    21 oct. 2025Replacement A replacement CS01 (Statement of Capital and Shareholder Information) was registered 21/10/25 as the original contained an error

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2023 au 28 févr. 2024

    1 pagesAA01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2022

    116 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed hurricane energy LIMITED\certificate issued on 23/06/23
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name23 juin 2023

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Qui sont les dirigeants de PRAX UPSTREAM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AMBA SECRETARIES LIMITED
    72 Welbeck Street
    Paddington Central, Kingdom Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    United Kingdom
    Secrétaire
    72 Welbeck Street
    Paddington Central, Kingdom Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement05876534
    115238010001
    COPELAND, Martin Francis David
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    Administrateur
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    EnglandBritish140268250001
    COX, Christopher Martin
    72 Welbeck Street
    Paddington Central, Kingdom Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    United Kingdom
    Administrateur
    72 Welbeck Street
    Paddington Central, Kingdom Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    United Kingdom
    EnglandBritish115341280003
    FEWKES, Daniel Charles
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    Administrateur
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    EnglandBritish197640080001
    KILLEEN, Michael Paul
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    Administrateur
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    ScotlandBritish303105930001
    LAMBERT, Stephen David
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    Administrateur
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    EnglandBritish207622530001
    CHAFFE, Richard Paul
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    295364170001
    JANKES, Daniel
    Abbey Mill Business Park
    GU7 2QN Lower Eashing
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    England
    Secrétaire
    Abbey Mill Business Park
    GU7 2QN Lower Eashing
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    England
    British163619260001
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Secrétaire
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    38915800008
    BREAMS REGISTRARS AND NOMINEES LIMITED
    52 Bedford Row
    WC1R 4LR London
    Secrétaire désigné
    52 Bedford Row
    WC1R 4LR London
    900002310001
    ELEMENTAL COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    Old Gloucester Street
    WC1N 3AX London
    27
    England
    Secrétaire
    Old Gloucester Street
    WC1N 3AX London
    27
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement07900133
    310044330001
    AGOSTINI, Alessandro
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    Administrateur
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    United KingdomBritish,Italian306719990001
    ALLAN, Robert Andrew
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish173055720001
    ARNOTT, Robert John
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    EnglandBritish181229190001
    BEAL, Linda Janice
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish296261060001
    BRIGGS, Nicholas Howard
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    EnglandBritish64953680004
    CHAFFE, Richard Paul
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish270532520001
    CHENG, Jason Aun Minn
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Hong KongAustralian223698720002
    CRAIK, David Ian
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish7978320001
    DAYER, Philip John
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    EnglandBritish157539810001
    GOOD, Charles Anthony
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    EnglandBritish6848410005
    GUEST, William James
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    British131051030001
    HARVEY, Russell Seth
    Hunters Croft
    Grayswood
    GU27 Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Hunters Croft
    Grayswood
    GU27 Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish23757260001
    HEANEY, Robert Charles
    Valais
    Les Grands Vaux
    JE2 7NA St Helier
    Channel Islands
    Administrateur
    Valais
    Les Grands Vaux
    JE2 7NA St Helier
    Channel Islands
    British117757070001
    HOGAN, John Anthony
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    United KingdomBritish94257040001
    HUDDLESTON, James Wallace
    Suite, 7th Floor, Building 170,
    Road 1703, Block 317
    Manama
    Bahrain
    Administrateur
    Suite, 7th Floor, Building 170,
    Road 1703, Block 317
    Manama
    Bahrain
    British105293960001
    JENKINS, David Anthony Lawson, Dr.
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    United KingdomBritish813330001
    KELLY, Roy Thomas
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    EnglandBritish207980930001
    KIRBY, Keith
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    United KingdomBritish162174610001
    MARDON TAYLOR, Nicholas John
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    EnglandBritish105294260003
    MARDON TAYLOR, Nicholas John
    52 Bedford Row
    London
    WC1R 4LR
    Administrateur
    52 Bedford Row
    London
    WC1R 4LR
    EnglandBritish105294260003
    MARIS, Antony Wayne
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Harvest House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish78957850001
    MCKENDRICK, Iain Charles
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    Administrateur
    72 Welbeck Street
    W1G 0AY London
    4th Floor
    Greater London
    England
    ScotlandBritish272476200001
    MCTIERNAN, Steven James
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    EnglandBritish245906980001
    MONTAGUE, Adrian Alastair, Sir
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Mill Business Park
    Lower Eashing
    GU7 2QN Godalming
    Ground Floor The Wharf
    Surrey
    United KingdomBritish162195170001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour PRAX UPSTREAM LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    24 juil. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0