P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED

P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéP A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéReceveur désigné
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05250795
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Élevage de bovins laitiers (01410) / Agriculture, sylviculture et pêche

    Où se situe P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Brynfa Farm
    Hermon
    SA36 0DZ Glogue
    Pembrokeshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le28 oct. 2015
    Date d'échéance des prochains comptes28 janv. 2017
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2014

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au04 oct. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation18 oct. 2016
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 17 nov. 2021

    4 pagesREC2
    AAI0CDER

    Nomination de Mr Paul Antony Vizza en tant qu'administrateur le 01 oct. 2021

    2 pagesAP01
    XAE7BM1D

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 17 nov. 2020

    4 pagesREC2
    A9K5J2QB

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01
    A8IQHW4W

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01
    A8IQHW54

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 04 avr. 2019

    4 pagesREC2
    A84GRL5T

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02
    A82Z6D7K

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 13 déc. 2018

    4 pagesREC2
    A7X0JRSI

    Notification de révocation d'un administrateur

    3 pagesAP01
    A7EPBPSX

    Cessation de la nomination de Shaw Elin Vizza en tant que directeur le 10 sept. 2018

    1 pagesTM01
    A7EPBPSH

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02
    Q7ALAUD5

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02
    Q7ALAUEX

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 06 juin 2018

    4 pagesREC2
    A79VQ3IX

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 13 juin 2018

    4 pagesREC2
    A78QQJZE

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02
    A77YOD81

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 13 déc. 2017

    4 pagesREC2
    A6XZP1G9

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 13 déc. 2017

    4 pagesREC2
    A6XZP1GX

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01
    A6XRYTQZ

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01
    A6XRYTQR

    Modification des coordonnées de l'administrateur Shaw Elin Vizza le 08 nov. 2017

    4 pagesCH01
    A6JQ0Q8J

    Nomination de Shaw Elin Vizza en tant qu'administrateur le 28 févr. 2017

    3 pagesAP01
    A63UA2GW

    Cessation de la nomination de Paul Antony Vizza en tant que directeur le 28 févr. 2017

    3 pagesTM01
    A62P1D0J

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 24 janv. 2017

    2 pages3.6
    A61CA18B

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02
    A5Z1M8ZL

    Qui sont les dirigeants de P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VIZZA, Paul
    Hermon
    SA36 0DZ Glogue
    Brynfa Farm
    Pembrokeshire
    Secrétaire
    Hermon
    SA36 0DZ Glogue
    Brynfa Farm
    Pembrokeshire
    155075430001
    VIZZA, Paul Antony
    Hermon
    SA36 0DZ Glogue
    Glogue
    Wales
    Administrateur
    Hermon
    SA36 0DZ Glogue
    Glogue
    Wales
    WalesBritishFarmer100717530002
    VIZZA, Marina May
    8 Tudor Close
    SA71 5QD Pembroke
    Dyfed
    Secrétaire
    8 Tudor Close
    SA71 5QD Pembroke
    Dyfed
    BritishHousewife100717560001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Secrétaire désigné
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    VIZZA, Paul Antony
    Brynfa Farm
    Hermon
    SA36 0DZ Glogue
    Pembrokeshire
    Administrateur
    Brynfa Farm
    Hermon
    SA36 0DZ Glogue
    Pembrokeshire
    WalesBritishDeveloper100717530002
    VIZZA, Shaw Elin
    Hermon
    SA36 0DZ Crymych
    Brynfa Farm
    Pembrokeshire
    Administrateur
    Hermon
    SA36 0DZ Crymych
    Brynfa Farm
    Pembrokeshire
    WalesBritishNone229269050002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Administrateur désigné
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 14 sept. 2009
    Livré le 23 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Brynfa farm hermon glogue pembrokeshire t/no's WA923111, CYM341026, WA923105, WA923101, WA923092, WA923108, WA522800 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 14 sept. 2009
    Livré le 23 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a castell and crugbach land and mountain hall land hermon glogue pembrokeshire t/no's WA732895, WA923117, WA923058 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 621 nov. 2019Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 6
    Legal charge
    Créé le 14 sept. 2009
    Livré le 18 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a brynfa hermon glogue pembrokeshire, t/no.WA92311, CYM341026,WA923105, WA923108, WA522800,WA923092 and WA923101.
    Personnes ayant droit
    • The Agricultural Mortgage Corporation PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 416 janv. 2018Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 420 juil. 2018Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 721 nov. 2019Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 4
      • Numéro de dossier 7
    Legal charge
    Créé le 14 sept. 2009
    Livré le 18 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of land at mountain hall crymych pembrokeshire, t/no.WA923058: land lying to the north west of the road leadfing from pentregalar to hermon pembrokeshire, t/no.WA923117: land on the east side of road leading from pentregalar to crymych, t/no.WA732895.
    Personnes ayant droit
    • The Agricultural Mortgage Corporation PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 516 janv. 2018Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 520 juil. 2018Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 5
    Debenture
    Créé le 10 sept. 2009
    Livré le 12 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 27 août 2008
    Livré le 28 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge
    Créé le 02 mai 2007
    Livré le 09 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    £116,140 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    37A conway drive milford haven pembrokeshire. Fixed charge over all rental income and.
    Personnes ayant droit
    • Capital Home Loans Limited
    Transactions
    • 09 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 216 déc. 2016Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 208 avr. 2019Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 2
    Deed of charge
    Créé le 17 avr. 2007
    Livré le 28 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    £116,140.00 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    31 conway drive milford haven pembrokesh. See the mortgage charge document for full details. Fixed charge over all rental income and.
    Personnes ayant droit
    • Capital Home Loans Limited (The Chargeholder)
    Transactions
    • 28 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 115 déc. 2016Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 112 juin 2018Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 1
    Deed of charge
    Créé le 17 avr. 2007
    Livré le 20 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    £116,140 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    27 conway drive milford haven pembrokeshire,. Fixed charge over all rental income and.
    Personnes ayant droit
    • Capital Home Loans Limited
    Transactions
    • 20 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 316 déc. 2016Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 328 janv. 2017Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 3
    Legal charge
    Créé le 15 sept. 2006
    Livré le 16 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Brynfa farm, hermon glogue, pembrokeshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 sept. 2006
    Livré le 13 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 août 2006
    Livré le 03 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a plots 13-26 inclusive and plots 37-48 inclusive conway drive, steynton, pembrokeshire t/no CYM270457 and all that property k/a plots 32-36 inclusive and plots 49-53 inclusive conway drive steynton, pembrokeshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 20 mars 2006
    Livré le 01 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £480,000.00 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    Plots 13-26 (inclusive) and plots(inclusive) conway drive steynton milford haven pembrokeshire.
    Personnes ayant droit
    • Swansea Building Society
    Transactions
    • 01 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    P A VIZZA DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Burton Hughes
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    receiver manager
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    Julian Paul Smith
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    receiver manager
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Burton Hughes
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    receiver manager
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    Julian Paul Smith
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    receiver manager
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    3Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Burton Hughes
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    receiver manager
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    Julian Paul Smith
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    receiver manager
    Pembroke House 15 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3BA Bristol
    4Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Brian Williams
    Windsor House St. Marys Street
    HR9 5HX Ross-On-Wye
    Herefordshire
    receiver manager
    Windsor House St. Marys Street
    HR9 5HX Ross-On-Wye
    Herefordshire
    5Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Brian Williams
    Windsor House St. Marys Street
    HR9 5HX Ross-On-Wye
    Herefordshire
    receiver manager
    Windsor House St. Marys Street
    HR9 5HX Ross-On-Wye
    Herefordshire
    6Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alistair Charles Wright
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    receiver manager
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon James Hunt
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    receiver manager
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    7Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alistair Charles Wright
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    receiver manager
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon James Hunt
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    receiver manager
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0