SAPIENTNITRO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSAPIENTNITRO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05253231
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SAPIENTNITRO LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SAPIENTNITRO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Eden House
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SAPIENTNITRO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NITRO LIMITED07 oct. 200407 oct. 2004

    Quels sont les derniers comptes de SAPIENTNITRO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SAPIENTNITRO LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SAPIENTNITRO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 oct. 2014

    État du capital au 31 oct. 2014

    • Capital: GBP 740,973
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Michael Chalmers Reid le 06 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Nigel Gregory Vaz en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Michael Chalmers Reid en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Clyde Secretaries Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Christian Oversohl en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Damien O'donohoe en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Damien O'donohoe en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 oct. 2013

    État du capital au 17 oct. 2013

    • Capital: GBP 740,973
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2010 au 30 juin 2011

    2 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    18 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 1St Floor 25 Bedford Street London WC2E 9ES* le 01 avr. 2010

    2 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Joseph Simeon Tibbetts Jr le 29 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Christian Oversohl le 29 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Damien Patrick Thomas O'donohoe le 29 mars 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de SAPIENTNITRO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLYDE SECRETARIES LIMITED
    Houndsditch
    EC3A 7AR London
    The St Botolph Building, 138
    United Kingdom
    Secrétaire
    Houndsditch
    EC3A 7AR London
    The St Botolph Building, 138
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02177318
    38770650001
    REID, John Michael Chalmers
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    Administrateur
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    ScotlandUnited KingdomVp Md Gen Management119578160001
    TIBBETTS JR, Joseph Simeon
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    Administrateur
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    United StatesUnited StatesSenior Vice President And Chief Financial Officer146961310001
    VAZ, Nigel Gregory
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    United Kingdom
    Administrateur
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    United Kingdom
    United KingdomUnited StatesDirector186325620001
    O'DONOHOE, Damien Patrick Thomas
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    Secrétaire
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    IrishFinancial Director131897840001
    SHEARER, Paul Gavin
    23 Whellock Road
    W14 1DY London
    Greater London
    Secrétaire
    23 Whellock Road
    W14 1DY London
    Greater London
    BritishCompany Director & Creative Di108266550001
    ABACUS LONDON LIMITED
    149a Masons Hill
    BR2 9HY Bromlet
    Kent
    Secrétaire
    149a Masons Hill
    BR2 9HY Bromlet
    Kent
    119028680001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Secrétaire désigné
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027310001
    CLARKE, Christopher
    526 Indian Field Road,
    Lot 526
    Greenwich
    Ct 06830
    Usa
    Administrateur
    526 Indian Field Road,
    Lot 526
    Greenwich
    Ct 06830
    Usa
    AustralianAdvertising Director102053520002
    CORMAN, Richard
    335 Greenwich St,
    Ya
    New York
    New York 10013
    Usa
    Administrateur
    335 Greenwich St,
    Ya
    New York
    New York 10013
    Usa
    U SExecutive108273420001
    CROUCH, Bruce James
    228 Meadvale Road
    Ealing
    W5 1LT London
    Administrateur
    228 Meadvale Road
    Ealing
    W5 1LT London
    United KingdomBritishCo Director27905020001
    DAVIDSON, William
    153 Oliphant Street
    W10 4EA London
    Administrateur
    153 Oliphant Street
    W10 4EA London
    BritishGlobal Operations Director127531970001
    HOWE, Catherine Susannah
    Kings Road
    SW6 2ES Fulham
    619
    London
    Administrateur
    Kings Road
    SW6 2ES Fulham
    619
    London
    United KingdomBritishMarketing159723360001
    O'DONOHOE, Damien Patrick Thomas
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    Administrateur
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    United KingdomIrishFinancial Director131897840001
    OVERSOHL, Christian, Dr
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    Administrateur
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    GermanyGermanSeniior Vice President146960610001
    SHEARER, Paul Gavin
    23 Whellock Road
    W4 1DY London
    Administrateur
    23 Whellock Road
    W4 1DY London
    BritishCo Director101441310001
    TOVRIE, Johan
    10 Elgin Court
    Elgin Avenue
    W9 2NU London
    Administrateur
    10 Elgin Court
    Elgin Avenue
    W9 2NU London
    South AfricanManaging Director119366260001
    WICKERSON, Susan Joan
    149a Masons Hill
    BR2 9HW Bromley
    Kent
    Administrateur
    149a Masons Hill
    BR2 9HW Bromley
    Kent
    BritishCo Director3764800002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Administrateur désigné
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027300001

    SAPIENTNITRO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2008
    Livré le 21 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Nitro Usa Inc
    Transactions
    • 21 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Share charge
    Créé le 04 avr. 2008
    Livré le 21 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its rights in the shares and any rights or other assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nitro Usa Inc
    Transactions
    • 21 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 05 juil. 2007
    Livré le 10 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 09 nov. 2006
    Livré le 11 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 11 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0