TM SEARCH CHOICE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TM SEARCH CHOICE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05281723 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TM SEARCH CHOICE LIMITED ?
Adresse du siège social | 1200 Delta Business Park SN5 7XZ Swindon Wiltshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TM SEARCH CHOICE LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TM SEARCH CHOICE LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 nov. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 18 nov. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 nov. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour TM SEARCH CHOICE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Nicholas Guy Richards en tant que directeur le 13 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2023 | 2 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Edward Albone en tant que directeur le 28 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2024 au 31 déc. 2024 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joseph David Pepper en tant que directeur le 18 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 052817230002 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charlie Maccready en tant que directeur le 03 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Warren Proud en tant que directeur le 03 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tom Durbin St George en tant que directeur le 03 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Johannes Maerz en tant qu'administrateur le 03 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022 | 2 pages | AA | ||||||||||
Statuts | 10 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Inscription de la charge 052817230002, créée le 28 avr. 2022 | 81 pages | MR01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Midland Bridge House Midland Bridge Road Bath BA2 3FP England à Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Courtyard House the Square Lightwater Surrey GU18 5SS England à 1200 Delta Business Park Swindon Wiltshire SN5 7XZ le 05 janv. 2022 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 2 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Charlie Maccready en tant qu'administrateur le 08 juil. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew Proud en tant qu'administrateur le 08 juil. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Tom Durbin St George en tant qu'administrateur le 08 juil. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1200 Delta Business Park Swindon Wiltshire SN5 7XZ England à Courtyard House the Square Lightwater Surrey GU18 5SS le 13 juil. 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TM SEARCH CHOICE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAERZ, Thomas Johannes | Administrateur | Delta Business Park SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire | Germany | German | Operating Partner | 312040390001 | ||||||||
BROWN, Trevor Haward | Secrétaire | Delta Business Park, Welton Road SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire United Kingdom | British | Chartered Accountant | 78303610002 | |||||||||
HODSON, William Laurence | Secrétaire | 27 Belvedere Grove Wimbledon SW19 7RQ London | British | Accountant | 94541480001 | |||||||||
STRIVENS, Andrew James | Secrétaire | 32 Sandfield Road OX3 7RJ Oxford Oxfordshire | British | Company Director | 102951400001 | |||||||||
RWK COMPANY SERVICES LIMITED | Secrétaire | Northumberland Buildings Queen Square BA1 2JE Bath 5-6 England |
| 101282840002 | ||||||||||
WK COMPANY SERVICES LIMITED | Secrétaire | 5 & 6 Northumberland Building Queen Square BA1 2JE Bath Avon | 101282840001 | |||||||||||
ALBONE, Paul Edward | Administrateur | Delta Business Park SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire | United Kingdom | British | Director | 121596030001 | ||||||||
BOBATH, Anthony John | Administrateur | Delta Business Park SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire England | England | British | Company Director | 179547630001 | ||||||||
BROWN, Trevor Haward | Administrateur | Delta Business Park, Welton Road SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 78303610002 | ||||||||
CAROLAN, John Francis | Administrateur | Delta Business Park SN5 7XD Swindon 200 Wiltshire United Kingdom | England | British | Company Director | 80312960001 | ||||||||
CRABB, Ian Denis | Administrateur | Floor 1/3 Sun Street EC2A 2EP London 4th England | England | British | Director | 181144470001 | ||||||||
CREFFIELD, Paul Lewis | Administrateur | Delta Business Park SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire England | United Kingdom | British | Director | 130655630001 | ||||||||
DURBIN ST GEORGE, Tom | Administrateur | The Square GU18 5SS Lightwater Courtyard House Surrey England | England | British | Director | 285119400001 | ||||||||
EDWARDS, Gordon Lewis | Administrateur | 3 Westover Drive ST15 8TT Stone Staffordshire | British | Managing Director | 127402130001 | |||||||||
EMBLEY, Simon David | Administrateur | Delta Business Park, Welton Road SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire United Kingdom | England | British | Company Director | 71406150003 | ||||||||
FOSTER, Steven James | Administrateur | Swandown Axford SN8 2EX Marlborough Wiltshire | England | British | Director | 69028400002 | ||||||||
GILBERT, Mark Anthony | Administrateur | Delta Business Park SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire England | England | British | Company Director | 247438620001 | ||||||||
GILL, Adrian Stuart | Administrateur | Richmond Barn Drayton Road MK17 0LE Mursley Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 66529100003 | ||||||||
HILL, Harry Douglas | Administrateur | Moat Hall Fordham CO6 3LU Colchester Essex | England | British | Director | 2505480001 | ||||||||
HODSON, William Laurence | Administrateur | 27 Belvedere Grove Wimbledon SW19 7RQ London | England | British | Accountant | 94541480001 | ||||||||
KEMP, Colin | Administrateur | Knott Barn Whitehill Lane Lothersdale BD20 8HX Skipton West Yorkshire | British | Company Director | 96584030001 | |||||||||
LAING, Ian Michael | Administrateur | 4 Charlbury Road OX2 6UT Oxford | England | British | Director | 2591720001 | ||||||||
LIVESEY, David Christopher | Administrateur | Hockliffe Street LU7 1GN Leighton Buzzard 16-20 Bedfordshire England | United Kingdom | British | Company Director | 226178270001 | ||||||||
MACCREADY, Charlie | Administrateur | The Square GU18 5SS Lightwater Courtyard House Surrey England | Canada | Canadian | Lawyer | 285121410001 | ||||||||
PEPPER, Joseph David | Administrateur | Delta Business Park SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire | England | British | Company Director | 245781260001 | ||||||||
PROUD, Matthew Warren | Administrateur | The Square GU18 5SS Lightwater Courtyard House Surrey England | Canada | Canadian | Director | 285156530001 | ||||||||
RICHARDS, Nicholas Guy | Administrateur | Delta Business Park SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire | England | British | Chartered Accountant | 267879040001 | ||||||||
SCARFF, Robert | Administrateur | 49 Sheep Street CV37 6EE Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Director | 103708830001 | |||||||||
SHIPPERLEY, Reginald Stephen | Administrateur | Home Farm Waterstock OX33 1JU Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 12798700001 | ||||||||
STRIVENS, Andrew James | Administrateur | 32 Sandfield Road OX3 7RJ Oxford Oxfordshire | British | Company Director | 102951400001 | |||||||||
WILLIAMS, Edmund Warren | Administrateur | Littlehurst House 154 Forest Road TN2 5JD Tunbridge Wells Kent | England | British | Managing Director | 74001820004 | ||||||||
WILLIAMS, Martyn Courtney Bailey | Administrateur | 9 Chadlington Road OX2 6SY Oxford | England | British | Director | 37614850003 | ||||||||
WK INCORPORATIONS LIMITED | Administrateur | 5 & 6 Northumberland Building Queen Square BA1 2JE Bath Avon | 101282830001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TM SEARCH CHOICE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tm Group (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | Delta Business Park SN5 7XZ Swindon 1200 Wiltshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0