REENERGY GROUP PLC
Vue d'ensemble
| Nom de la société | REENERGY GROUP PLC |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société anonyme cotée en bourse |
| Numéro de société | 05281827 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe REENERGY GROUP PLC ?
| Adresse du siège social | Bloxam Court Corporation Street CV21 2DU Rugby Warwickshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de REENERGY GROUP PLC ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour REENERGY GROUP PLC ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Nomination de Mr John Francis Liwosz en tant qu'administrateur le 28 mai 2012 | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 5 pages | DS01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Cottage, Grove Farm Jacobean Lane Knowle Solihull B93 9LP le 17 mai 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
legacy | 5 pages | MG01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 31 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Legal Clarity Limited en tant que secrétaire le 12 août 2010 | 3 pages | AP04 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 2 pages | AD03 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 2 pages | AD02 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 15 août 2011
| 6 pages | SH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 46 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Détails de la variation des droits attachés aux actions | 2 pages | SH10 | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Subdivision des actions au 17 janv. 2011 | 6 pages | SH02 | ||||||||||||||
Consolidation des actions au 17 janv. 2011 | 6 pages | SH02 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 25 mai 2011
| 5 pages | SH01 | ||||||||||||||
Statuts | 45 pages | MA | ||||||||||||||
Nomination de Sarah Jane Fellows en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Michael George Fellows en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 30 pages | AR01 | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de REENERGY GROUP PLC ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGAL CLARITY LIMITED | Secrétaire | 45-51 Newhall Street B3 3QR Birmingham Cornwall Buildings England |
| 150127440001 | ||||||||||
| ALLEN, Jonathan | Administrateur | Jacobean Lane Knowle B93 9LP Solihull The Cottage,Grove Farm England | United Kingdom | British | 146337180001 | |||||||||
| FELLOWS, Michael George | Administrateur | Church Road BN18 0EW Yapton Yew Tree Cottage West Sussex | England | British | 38260390001 | |||||||||
| FELLOWS, Sarah Jane | Administrateur | Rosemead BN17 6UH Littlehampton 8 West Sussex | United Kingdom | British | 161563120001 | |||||||||
| LIWOSZ, John Francis | Administrateur | Corporation Street CV21 2DU Rugby Bloxam Court Warwickshire | Great Britain | British | 69814250001 | |||||||||
| NEVILLE, Michael Patrick | Administrateur | Jacobean Lane Knowle B93 9LP Solihull The Cottage, Grove Farm England | England | British | 111036630002 | |||||||||
| CLARKE, Marilyn Elizabeth Wulff | Secrétaire | 17 C Kent House Road SE26 5LN London | British | 108890170001 | ||||||||||
| CRAVEN, Paul Gerard | Secrétaire | Brook Cottage Lower Stanton St Quintin SN14 6BY Chippenham Wiltshire | British | 102862920001 | ||||||||||
| HERBERT, Maxwell Glyn | Secrétaire | Sheepwalk House 38a Ridgway Wimbledon Village SW19 4QW London | British | 104536030001 | ||||||||||
| HEWITT, Michael Roger | Secrétaire | Old Stocks Valley Road Hughenden Valley HP14 4PF High Wycombe Bucks | British | 915020001 | ||||||||||
| JONES, Grant, Doctor | Secrétaire | Drake Lane GL11 5HD Upper Cam Lansdowne Gloucestershire | British | 135694470001 | ||||||||||
| SELLINGS, Roy David | Secrétaire | Ely Place EC1N 6TD London 31-32 | British | 153028840001 | ||||||||||
| SNOW HILL SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 24 Britton Street EC1M 5UA London | 114522640001 | |||||||||||
| ALLEN, Jonathan | Administrateur | Flax Barn Leamington Road CV47 9QF Long Itchington Warwickshire | United Kingdom | British | 125506400001 | |||||||||
| BIFFEN, Andrew Paul | Administrateur | The Brambles Theescombe Lane Amberley GL5 5AZ Stroud Glos | England | British | 121533850001 | |||||||||
| CRAVEN, Paul Gerard | Administrateur | Brook Cottage Lower Stanton St Quintin SN14 6BY Chippenham Wiltshire | England | British | 102862920001 | |||||||||
| FLIGHT, Howard Emerson, Lord | Administrateur | 6 Barton Street Westminster SW1P 3NG London | England | British | 71333400002 | |||||||||
| HARCOURT, Brian Leslie | Administrateur | G4, 173 Mounts Bay 6000 Perth Western Australia Australia | British | 101286430001 | ||||||||||
| HAY, Morven Charles | Administrateur | Eastfields Avenue SW18 1LR London 102 Chapelier House | England | British | 128275500001 | |||||||||
| HEWITT, Michael Roger | Administrateur | Old Stocks Valley Road Hughenden Valley HP14 4PF High Wycombe Bucks | England | British | 915020001 | |||||||||
| JENNINGS, Daniel William Thomas | Administrateur | Arundel Way Cawston CV22 7TU Rugby 16 Warwickshire | England | British | 139763450001 | |||||||||
| JONES, Grant, Doctor | Administrateur | Drake Lane GL11 5HD Upper Cam Lansdowne Gloucestershire | British | 135694470001 | ||||||||||
| KEAST, Wayne Bruce | Administrateur | 403 Chapelier House Eastfields Avenue SW18 1LR London | United Kingdom | British | 84242170002 | |||||||||
| MORGAN, Arthur William Crawford | Administrateur | Bovingdon SL7 2QR Marlow Common Buckinghamshire | United Kingdom | British | 38936880001 | |||||||||
| MUELLER, Steven Jay | Administrateur | 3205 Oliphant Street FOREIGN San Diego California 92106-1922 Usa | Usa | 110132540001 | ||||||||||
| NEVILLE, Michael Patrick | Administrateur | Knowle Wood Road Dorridge B93 8JN Solihull 32 West Midlands | England | British | 111036630002 | |||||||||
| SMYTH, Robert Franklin | Administrateur | Tangier Road GU1 2DE Guildford 3 Surrey | England | British | 26738380001 | |||||||||
| STROBECK, Gordon Lee | Administrateur | Woodfield Way RG7 5AB Theale 55 Berkshire | Uk | United States | 148959790001 |
REENERGY GROUP PLC a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 20 févr. 2012 Livré le 10 mars 2012 | En cours | Montant garanti £238,130.83 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The entire issued capital of fellows international limited, held in the sole name of reenergy group PLC. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 04 janv. 2011 Livré le 11 janv. 2011 | En cours | Montant garanti £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The tax losses of the company as at 27 august 2010, proceeds of any sale of such losses see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 13 avr. 2006 Livré le 21 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0