REENERGY GROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREENERGY GROUP PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 05281827
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REENERGY GROUP PLC ?

    • Production d'électricité (35110) / Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
    • Collecte, traitement et distribution d'eau (36000) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution
    • Collecte de déchets non dangereux (38110) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe REENERGY GROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    Bloxam Court
    Corporation Street
    CV21 2DU Rugby
    Warwickshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de REENERGY GROUP PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour REENERGY GROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Nomination de Mr John Francis Liwosz en tant qu'administrateur le 28 mai 2012

    3 pagesAP01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    5 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de The Cottage, Grove Farm Jacobean Lane Knowle Solihull B93 9LP le 17 mai 2012

    2 pagesAD01

    legacy

    5 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    31 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 févr. 2012

    État du capital au 20 févr. 2012

    • Capital: GBP 850,903.25
    SH01

    Nomination de Legal Clarity Limited en tant que secrétaire le 12 août 2010

    3 pagesAP04

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    État du capital après une attribution d'actions au 15 août 2011

    • Capital: GBP 5,890,325.00
    6 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    46 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    17 pagesAA

    Subdivision des actions au 17 janv. 2011

    6 pagesSH02

    Consolidation des actions au 17 janv. 2011

    6 pagesSH02

    État du capital après une attribution d'actions au 25 mai 2011

    • Capital: GBP 5,090,325
    5 pagesSH01

    Statuts

    45 pagesMA

    Nomination de Sarah Jane Fellows en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Michael George Fellows en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    30 pagesAR01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Qui sont les dirigeants de REENERGY GROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEGAL CLARITY LIMITED
    45-51 Newhall Street
    B3 3QR Birmingham
    Cornwall Buildings
    England
    Secrétaire
    45-51 Newhall Street
    B3 3QR Birmingham
    Cornwall Buildings
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6452925
    150127440001
    ALLEN, Jonathan
    Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    The Cottage,Grove Farm
    England
    Administrateur
    Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    The Cottage,Grove Farm
    England
    United KingdomBritish146337180001
    FELLOWS, Michael George
    Church Road
    BN18 0EW Yapton
    Yew Tree Cottage
    West Sussex
    Administrateur
    Church Road
    BN18 0EW Yapton
    Yew Tree Cottage
    West Sussex
    EnglandBritish38260390001
    FELLOWS, Sarah Jane
    Rosemead
    BN17 6UH Littlehampton
    8
    West Sussex
    Administrateur
    Rosemead
    BN17 6UH Littlehampton
    8
    West Sussex
    United KingdomBritish161563120001
    LIWOSZ, John Francis
    Corporation Street
    CV21 2DU Rugby
    Bloxam Court
    Warwickshire
    Administrateur
    Corporation Street
    CV21 2DU Rugby
    Bloxam Court
    Warwickshire
    Great BritainBritish69814250001
    NEVILLE, Michael Patrick
    Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    The Cottage, Grove Farm
    England
    Administrateur
    Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    The Cottage, Grove Farm
    England
    EnglandBritish111036630002
    CLARKE, Marilyn Elizabeth Wulff
    17 C Kent House Road
    SE26 5LN London
    Secrétaire
    17 C Kent House Road
    SE26 5LN London
    British108890170001
    CRAVEN, Paul Gerard
    Brook Cottage
    Lower Stanton St Quintin
    SN14 6BY Chippenham
    Wiltshire
    Secrétaire
    Brook Cottage
    Lower Stanton St Quintin
    SN14 6BY Chippenham
    Wiltshire
    British102862920001
    HERBERT, Maxwell Glyn
    Sheepwalk House
    38a Ridgway Wimbledon Village
    SW19 4QW London
    Secrétaire
    Sheepwalk House
    38a Ridgway Wimbledon Village
    SW19 4QW London
    British104536030001
    HEWITT, Michael Roger
    Old Stocks Valley Road
    Hughenden Valley
    HP14 4PF High Wycombe
    Bucks
    Secrétaire
    Old Stocks Valley Road
    Hughenden Valley
    HP14 4PF High Wycombe
    Bucks
    British915020001
    JONES, Grant, Doctor
    Drake Lane
    GL11 5HD Upper Cam
    Lansdowne
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Drake Lane
    GL11 5HD Upper Cam
    Lansdowne
    Gloucestershire
    British135694470001
    SELLINGS, Roy David
    Ely Place
    EC1N 6TD London
    31-32
    Secrétaire
    Ely Place
    EC1N 6TD London
    31-32
    British153028840001
    SNOW HILL SECRETARIES LIMITED
    24 Britton Street
    EC1M 5UA London
    Secrétaire
    24 Britton Street
    EC1M 5UA London
    114522640001
    ALLEN, Jonathan
    Flax Barn
    Leamington Road
    CV47 9QF Long Itchington
    Warwickshire
    Administrateur
    Flax Barn
    Leamington Road
    CV47 9QF Long Itchington
    Warwickshire
    United KingdomBritish125506400001
    BIFFEN, Andrew Paul
    The Brambles
    Theescombe Lane Amberley
    GL5 5AZ Stroud
    Glos
    Administrateur
    The Brambles
    Theescombe Lane Amberley
    GL5 5AZ Stroud
    Glos
    EnglandBritish121533850001
    CRAVEN, Paul Gerard
    Brook Cottage
    Lower Stanton St Quintin
    SN14 6BY Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Brook Cottage
    Lower Stanton St Quintin
    SN14 6BY Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish102862920001
    FLIGHT, Howard Emerson, Lord
    6 Barton Street
    Westminster
    SW1P 3NG London
    Administrateur
    6 Barton Street
    Westminster
    SW1P 3NG London
    EnglandBritish71333400002
    HARCOURT, Brian Leslie
    G4, 173 Mounts Bay
    6000 Perth
    Western Australia
    Australia
    Administrateur
    G4, 173 Mounts Bay
    6000 Perth
    Western Australia
    Australia
    British101286430001
    HAY, Morven Charles
    Eastfields Avenue
    SW18 1LR London
    102 Chapelier House
    Administrateur
    Eastfields Avenue
    SW18 1LR London
    102 Chapelier House
    EnglandBritish128275500001
    HEWITT, Michael Roger
    Old Stocks Valley Road
    Hughenden Valley
    HP14 4PF High Wycombe
    Bucks
    Administrateur
    Old Stocks Valley Road
    Hughenden Valley
    HP14 4PF High Wycombe
    Bucks
    EnglandBritish915020001
    JENNINGS, Daniel William Thomas
    Arundel Way
    Cawston
    CV22 7TU Rugby
    16
    Warwickshire
    Administrateur
    Arundel Way
    Cawston
    CV22 7TU Rugby
    16
    Warwickshire
    EnglandBritish139763450001
    JONES, Grant, Doctor
    Drake Lane
    GL11 5HD Upper Cam
    Lansdowne
    Gloucestershire
    Administrateur
    Drake Lane
    GL11 5HD Upper Cam
    Lansdowne
    Gloucestershire
    British135694470001
    KEAST, Wayne Bruce
    403 Chapelier House
    Eastfields Avenue
    SW18 1LR London
    Administrateur
    403 Chapelier House
    Eastfields Avenue
    SW18 1LR London
    United KingdomBritish84242170002
    MORGAN, Arthur William Crawford
    Bovingdon
    SL7 2QR Marlow Common
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Bovingdon
    SL7 2QR Marlow Common
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish38936880001
    MUELLER, Steven Jay
    3205 Oliphant Street
    FOREIGN San Diego
    California 92106-1922
    Usa
    Administrateur
    3205 Oliphant Street
    FOREIGN San Diego
    California 92106-1922
    Usa
    Usa110132540001
    NEVILLE, Michael Patrick
    Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JN Solihull
    32
    West Midlands
    Administrateur
    Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JN Solihull
    32
    West Midlands
    EnglandBritish111036630002
    SMYTH, Robert Franklin
    Tangier Road
    GU1 2DE Guildford
    3
    Surrey
    Administrateur
    Tangier Road
    GU1 2DE Guildford
    3
    Surrey
    EnglandBritish26738380001
    STROBECK, Gordon Lee
    Woodfield Way
    RG7 5AB Theale
    55
    Berkshire
    Administrateur
    Woodfield Way
    RG7 5AB Theale
    55
    Berkshire
    UkUnited States148959790001

    REENERGY GROUP PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 20 févr. 2012
    Livré le 10 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    £238,130.83 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The entire issued capital of fellows international limited, held in the sole name of reenergy group PLC.
    Personnes ayant droit
    • Jack Allen Holdings Limited
    Transactions
    • 10 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 04 janv. 2011
    Livré le 11 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The tax losses of the company as at 27 august 2010, proceeds of any sale of such losses see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jack Allen Holdings Limited
    Transactions
    • 11 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 13 avr. 2006
    Livré le 21 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Strand Partners Limited
    Transactions
    • 21 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0