CE SECURITY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCE SECURITY LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05289636
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CE SECURITY LIMITED ?

    • Activités de sécurité privée (80100) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe CE SECURITY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Frp Advisory Trading Limited St. Nicholas Court
    25-27 Castle Gate
    NG1 7AR Nottingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CE SECURITY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OCTAVIAN CONTINENTAL LIMITED17 nov. 200417 nov. 2004

    Quels sont les derniers comptes de CE SECURITY LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le29 nov. 2017
    Date d'échéance des prochains comptes29 août 2018
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 nov. 2016

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CE SECURITY LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au21 nov. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation05 déc. 2017
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au21 nov. 2016
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour CE SECURITY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 juil. 2024

    23 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 juil. 2023

    30 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 juil. 2022

    26 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Frp Advisory Llp Stanford House 19 Castle Gate Nottingham NG1 7AQ à C/O Frp Advisory Trading Limited St. Nicholas Court 25-27 Castle Gate Nottingham NG1 7AR le 17 juin 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 juil. 2021

    24 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 juil. 2020

    23 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Earl Edward Knight en tant que directeur le 31 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    31 pagesAM22

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    34 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    37 pagesAM10

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    38 pagesAM03

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Changement d'adresse du siège social de Ce House Alder Court Rennie Hogg Road, Riverside Business Park Nottingham Nottinghamshire NG2 1NX England à Frp Advisory Llp Stanford House 19 Castle Gate Nottingham NG1 7AQ le 24 août 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Satisfaction de la charge 052896360007 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 052896360009, créée le 17 juil. 2017

    15 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 29 nov. 2016

    29 pagesAA

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 29 nov. 2015

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2016 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Nomination de Mr Earl Edward Knight en tant qu'administrateur le 08 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Tomas Gronager en tant que directeur le 08 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Trevor James East en tant que directeur le 08 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 nov. 2015 au 29 nov. 2015

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de CE SECURITY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HALLETT, Anthony Philip
    St. Nicholas Court
    25-27 Castle Gate
    NG1 7AR Nottingham
    C/O Frp Advisory Trading Limited
    Administrateur
    St. Nicholas Court
    25-27 Castle Gate
    NG1 7AR Nottingham
    C/O Frp Advisory Trading Limited
    EnglandBritishCompany Director174367800001
    MCROBERTS, John Alexander
    St. Nicholas Court
    25-27 Castle Gate
    NG1 7AR Nottingham
    C/O Frp Advisory Trading Limited
    Administrateur
    St. Nicholas Court
    25-27 Castle Gate
    NG1 7AR Nottingham
    C/O Frp Advisory Trading Limited
    EnglandIrishChartered Accountant159663950001
    BILLAN, Sundeep
    Alder Court
    Riverside Business Park Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    Octavian House
    Nottingham
    England
    Secrétaire
    Alder Court
    Riverside Business Park Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    Octavian House
    Nottingham
    England
    175436510001
    GHUMAN, Kiranjit
    1 Serpentine Close
    Radcliffe On Trent
    NG12 2NS Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    1 Serpentine Close
    Radcliffe On Trent
    NG12 2NS Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director114742950001
    GHUMAN, Sukhjit Singh
    1 Serpentine Close
    Radcliffe On Trent
    NG12 2NS Nottingham
    Nottinghamshire
    U.K
    Secrétaire
    1 Serpentine Close
    Radcliffe On Trent
    NG12 2NS Nottingham
    Nottinghamshire
    U.K
    BritishCompany Director87738600002
    JONES, Adrian Martin Stuart
    Empire Way
    HA9 0PA Wembley
    York House 7th Floor - South Wing
    Middlesex
    England
    Secrétaire
    Empire Way
    HA9 0PA Wembley
    York House 7th Floor - South Wing
    Middlesex
    England
    200743020001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900015000001
    BITTER, Sarbjit Singh
    Wye Close
    DE65 5LH Hilton
    7
    Derbyshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wye Close
    DE65 5LH Hilton
    7
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector61543400002
    EAST, Trevor James
    Alder Court
    Rennie Hogg Road, Riverside Business Park
    NG2 1NX Nottingham
    Ce House
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Alder Court
    Rennie Hogg Road, Riverside Business Park
    NG2 1NX Nottingham
    Ce House
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritishCompany Director141451970001
    ENGELBRECHT, Josias Andrias
    Alder Court
    Riverside Business Park Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    Octavian House
    Nottingham
    England
    Administrateur
    Alder Court
    Riverside Business Park Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    Octavian House
    Nottingham
    England
    United KingdomBritishDirector108096280002
    ENGLEBRECHT, Josias Andrias
    Hotspur Drive
    Colwick
    NG4 2BS Nottingham
    34
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hotspur Drive
    Colwick
    NG4 2BS Nottingham
    34
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomSouth AfricanDirector147345050001
    GHUMAN, Kiranjit Kaur
    Syerston Hall Park
    Syerston
    NG23 5NL Newark
    Syerston Hall
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Syerston Hall Park
    Syerston
    NG23 5NL Newark
    Syerston Hall
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritishDirector147335640001
    GHUMAN, Simerjeet Kaur
    39 Buckingham Road
    LE67 4PB Coalville
    Leicestershire
    Administrateur
    39 Buckingham Road
    LE67 4PB Coalville
    Leicestershire
    BritishCompany Director104019860001
    GHUMAN, Sukhjit Singh
    Alder Court
    Riverside Business Park Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    Octavian House
    Nottingham
    England
    Administrateur
    Alder Court
    Riverside Business Park Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    Octavian House
    Nottingham
    England
    EnglandBritishDirector150306900001
    GHUMAN, Sukhjit Singh
    1 Serpentine Close
    Radcliffe On Trent
    NG12 2NS Nottingham
    Nottinghamshire
    U.K
    Administrateur
    1 Serpentine Close
    Radcliffe On Trent
    NG12 2NS Nottingham
    Nottinghamshire
    U.K
    EnglandBritishCompany Director87738600002
    GRONAGER, Tomas
    Alder Court
    Rennie Hogg Road, Riverside Business Park
    NG2 1NX Nottingham
    Ce House
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Alder Court
    Rennie Hogg Road, Riverside Business Park
    NG2 1NX Nottingham
    Ce House
    Nottinghamshire
    England
    EnglandDanishChief Executive Officer142381520001
    JONES, Adrian Martin Stuart
    Empire Way
    HA9 0PA Wembley
    York House 7th Floor - South Wing
    Middlesex
    England
    Administrateur
    Empire Way
    HA9 0PA Wembley
    York House 7th Floor - South Wing
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCertified Chartered Accountant214647980001
    KNIGHT, Earl Edward
    Stanford House
    19 Castle Gate
    NG1 7AQ Nottingham
    Frp Advisory Llp
    Administrateur
    Stanford House
    19 Castle Gate
    NG1 7AQ Nottingham
    Frp Advisory Llp
    EnglandBritishManaging Director214244980001
    OBEROI, Kavita
    Alder Court
    Riverside Business Park Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    Octavian House
    Nottingham
    England
    Administrateur
    Alder Court
    Riverside Business Park Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    Octavian House
    Nottingham
    England
    EnglandBritishDirector77737510001
    PAWAR, Avhninder
    31 The Parkway
    WS4 1XB Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    31 The Parkway
    WS4 1XB Walsall
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director89720990001
    SHEIKH, Reshma
    Alder Court
    Riverside Business Park Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    Octavian House
    Nottingham
    Administrateur
    Alder Court
    Riverside Business Park Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    Octavian House
    Nottingham
    EnglandBritishDirector184364500001
    SINGH, Santokh
    Braford Gardens
    Shenley Brook End
    MK5 7HY Milton Keynes
    74
    United Kingdom
    Administrateur
    Braford Gardens
    Shenley Brook End
    MK5 7HY Milton Keynes
    74
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector148092400001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900014990001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CE SECURITY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ceh Limited
    C/O Praxis Ifm
    Le Truchot
    PO BOX 296
    GY1 4NA Guernsey
    Sarnia House
    Guernsey
    06 avr. 2016
    C/O Praxis Ifm
    Le Truchot
    PO BOX 296
    GY1 4NA Guernsey
    Sarnia House
    Guernsey
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementGuernsey
    Autorité légaleGuernsey
    Lieu d'enregistrementGuernsey
    Numéro d'enregistrement60754
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CE SECURITY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 juil. 2017
    Livré le 24 juil. 2017
    En cours
    Brève description
    Fixed and floating charge. 'I. All freehold or leasehold property of the company with all present and future buildings, fixtures (trade fixtures) plant and machinery which are on such property. Ii. All patents, patent applications, inventions, trade marks, service marks (whether registered or no), trade names, design rights, registered designs, copyrights, know-how, trade secrets, rights ion computer software and any other intellectual or intangible property rights (including the benefit of any licences or consents.'.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Skipton Business Finance Limited
    Transactions
    • 24 juil. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 juin 2016
    Livré le 23 juin 2016
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Security Trustee Services Limited
    Transactions
    • 23 juin 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 18 août 2015
    Livré le 19 août 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    A. by way of first legal mortgage the specified real property.. B by way of first fixed charge:. (I) all real property;. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property;. C. by way of first fixed charge the intellectual property;. "Real property" means all estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (wherever situated) now or in future belonging to the obligor, or in which the obligor has an interest at any time, together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof; and. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof;. "Intellectual property rights" means:. (I) any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know-how and other intellectual property rights and interests whether registered or unregistered; and. (Ii) the benefit of all applications and rights to use such assets of the company.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shawbrook Bank Limited
    Transactions
    • 19 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 06 févr. 2013
    Livré le 08 févr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company or to become due to the group members (or any of them) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC as Security Trustee (Security Holder) for Each Group Member
    Transactions
    • 08 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 janv. 2013
    Livré le 23 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC as Security Trustee (Security Holder) for Each Group Member
    Transactions
    • 23 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 19 juil. 2012
    Livré le 24 juil. 2012
    En cours
    Montant garanti
    £17,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All the rent deposit monies.
    Personnes ayant droit
    • Mc Nominees LTD (For Mc Trustees LTD & Re Pullan) and Mc Nominees LTD (for Mc Trustees LTD & B Cappuccini)
    Transactions
    • 24 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 19 juil. 2012
    Livré le 24 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The companys debts by way of first floating charge see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Oberoi Consulting Limited
    Transactions
    • 24 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 23 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 14 janv. 2010
    Livré le 15 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibhy Financial Services Limited
    Transactions
    • 15 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 déc. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 janv. 2010
    Livré le 15 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octavian Security Limited (In Administration) Stanley Donald Burkett-Coltman and Peter Andrew Blair (Joint Administrator)
    Transactions
    • 15 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    CE SECURITY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 juil. 2017Administration started
    25 juil. 2019Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Anthony Lowe
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire
    practitioner
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire
    Nathan Jones
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire
    practitioner
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire
    2
    DateType
    25 juil. 2019Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nathan Jones
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire
    practitioner
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire
    John Anthony Lowe
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire
    practitioner
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0