PBS HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PBS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05297966 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PBS HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Brookfield Court Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PBS HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 mars 2022 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PBS HOLDINGS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 sept. 2023 |
Quels sont les derniers dépôts pour PBS HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Période comptable précédente prolongée du 30 mars 2023 au 29 sept. 2023 | 1 pages | AA01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 30 mars 2022 | 21 pages | AA | ||
Nomination de Mr Shane O’Neill en tant qu'administrateur le 24 oct. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Timothy John Smyth en tant que directeur le 24 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Penelope Jane Fullerton en tant que secrétaire le 24 oct. 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Changement d'adresse du siège social de 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England à Brookfield Court Selby Road Garforth Leeds LS25 1NB le 26 sept. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 30 mars 2021 | 21 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Elizabeth Anne Brophy en tant que secrétaire le 31 mai 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mrs Penelope Jane Fullerton en tant que secrétaire le 01 juin 2022 | 2 pages | AP03 | ||
Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2021 au 30 mars 2021 | 1 pages | AA01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2020 | 19 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England à 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG le 17 août 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 3 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England à 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG le 17 août 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Changement d'adresse du siège social de The Hamlet Hornbeam Park Harrogate HG2 8RE England à 3 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG le 03 août 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Miles Skingle en tant que directeur le 27 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2019 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2018 | 19 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de PBS HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O’NEILL, Shane | Administrateur | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | England | Irish | 301599440001 | |||||
| BLOTT, Stephen | Secrétaire | Low Wood Wilsden BD15 0JS Bradford 30 West Yorkshire England | British | 139352410001 | ||||||
| BROPHY, Elizabeth Anne | Secrétaire | Selby Road Swillington Common LS15 4LG Leeds 3.1 Carrwood Park West Yorkshire England | 247170400001 | |||||||
| FULLERTON, Penelope Jane | Secrétaire | Beck Road BD16 3JN Bingley Holroyd House England | 296527630001 | |||||||
| FULLERTON, Penelope Jane | Secrétaire | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 184072210001 | |||||||
| KEILL, Tracy Elizabeth | Secrétaire | 'Verandah House' 8 Pokiok Road Smith's Fl05 Bermuda | British | 127332980001 | ||||||
| MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre | Secrétaire | 39 Lynwood Grove BR6 0BD Orpington Kent | British | 75598460002 | ||||||
| ORTON, Jeffrey Christopher | Secrétaire | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | 185574260001 | |||||||
| ZACZKIEWICZ, Stacey | Secrétaire | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire Uk | 170327450001 | |||||||
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
| THOMAS EGGAR SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | The Corn Exchange Baffins Lane PO19 1GE Chichester West Sussex | 37896530011 | |||||||
| ALEXANDER, Laura Catherine Elizabeth | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 268740360001 | |||||
| AMISS, Michael Hamilton | Administrateur | 207 Key Palm Road Boca Raton Florida 33432 Usa | British | 100929450001 | ||||||
| BARCLAY, Ian James | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 184779440002 | |||||
| BEALES, Karen Anne | Administrateur | Marling Road Ainley Top HD2 2EE Huddersfield The Chalet Uk | England | British | 135540180002 | |||||
| BRADBURY, Susan Patricia | Administrateur | Causeway Foot Rochdale Road Pole Moor Outlane HD3 3FQ Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 40471660002 | |||||
| DAVEY, Jonathan Mark | Administrateur | 6 Mill Close Lane Patrick Brompton DL8 1AJ Bedale North Yorkshire | England | British | 81484820003 | |||||
| GILL, Ryan Mark | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 184068890001 | |||||
| HODES, Jonathan | Administrateur | 81 Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London | British | 79523100001 | ||||||
| HUBBARD, Peter John | Administrateur | Sevenleaze Lane Edge GL6 6NL Stroud Huddaknoll House Gloucestershire United Kingdom | England | British | 28375870003 | |||||
| JEWELL, Paul John | Administrateur | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | England | British | 221544490001 | |||||
| KEATING, Michael Samuel | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 135065160001 | |||||
| LAIRD, Oliver Walter | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire Uk | United Kingdom | British | 233726140001 | |||||
| LEIGHTON, Maria Louise | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 202291580001 | |||||
| MARLEY, Nicholas James | Administrateur | 6 The Brambles Woodside SW19 7AY London | United Kingdom | British | 113304050001 | |||||
| NATHAN, Clive Adam | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 207013760001 | |||||
| POSNER, Howard Michael | Administrateur | Stocks Lane HX2 6PR Luddenden Eaves House Halifax | United Kingdom | British | 139631580001 | |||||
| ROLFE, Timothy Paul | Administrateur | 9 Overhill CR6 9JR Warlingham Surrey | England | British | 107872640001 | |||||
| ROUSE, Jonathan Edward | Administrateur | 10 Osprey House 5 Victory Place Northey Street E14 8BG London | United Kingdom | British | 99883240002 | |||||
| SAGGU, Ranvir Singh | Administrateur | 21 Kearton Close CR8 5EN Kenley Surrey | England | British | 115958310001 | |||||
| SKINGLE, Richard Miles | Administrateur | Hornbeam Park HG2 8RE Harrogate The Hamlet England | England | British | 203052180001 | |||||
| SMITH, Malachy Paul | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire Uk | Ireland | Irish | 262619320001 | |||||
| SMYTH, Timothy John | Administrateur | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | England | British | 77794000006 | |||||
| SMYTH, Timothy John | Administrateur | 2 Knoll Road RH4 3EW Dorking Surrey | United Kingdom | British | 77794000002 | |||||
| WARREN, Michael Ian | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire Uk | England | British | 140310390001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PBS HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural & Commercial Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park LS10 1RJ Leeds Cast House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0