SAFRAN HOMES LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SAFRAN HOMES LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05298486 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SAFRAN HOMES LTD ?
| Adresse du siège social | 43a Wordsworth Road BN11 3JB Worthing West Sussex England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SAFRAN HOMES LTD ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SAFRAN HOMES LTD ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour SAFRAN HOMES LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Coughlan en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Olivia Wood Thorpe en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nadine Lennon en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 15 St. Leonards Road Epsom Downs Surrey KT18 5RG* le 06 déc. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 10 pages | MG01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 16 Starrock Road Coulsdon Surrey CR5 3EH England* le 18 mai 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Nadine Wood Thorpe le 05 mai 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 1 Magellan Terrace Gatwick Road Crawley West Sussex RH10 9PJ* le 10 mai 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Jerry Hannah le 26 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Nadine Wood Thorpe le 26 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Olivia Wood Thorpe le 26 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Robert Coughlan le 26 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr James Jerry Hannah le 26 nov. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SAFRAN HOMES LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANNAH, James Jerry | Secrétaire | Wordsworth Road BN11 3JB Worthing 43a West Sussex England | British | 103169170002 | ||||||
| HANNAH, James Jerry | Administrateur | Wordsworth Road BN11 3JB Worthing 43a West Sussex England | United Kingdom | British | 103169170002 | |||||
| MOORCRAFT, Graham Paul | Secrétaire | 12 Russells KT20 5TJ Tadworth Surrey | British | 97386270001 | ||||||
| @UKPLC CLIENT SECRETARY LTD | Secrétaire désigné | 5, Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading | 900025730001 | |||||||
| COUGHLAN, Robert Christopher | Administrateur | Wordsworth Road BN11 3JB Worthing 43a West Sussex England | United Kingdom | British | 106758630002 | |||||
| CRESSWELL, Gary | Administrateur | Red Chimneys The Drive KT5 9RG South Cheam Surrey | British | 103169430001 | ||||||
| FITZGERALD, Brendan David | Administrateur | 39 Dale Road CR8 2ED Purley Surrey | England | British | 61628390002 | |||||
| LENNON, Nadine | Administrateur | Wordsworth Road BN11 3JB Worthing 43a West Sussex England | United Kingdom | British | 116421050002 | |||||
| MOORCRAFT, Graham Paul | Administrateur | 12 Russells KT20 5TJ Tadworth Surrey | United Kingdom | British | 97386270001 | |||||
| WEBSTER, Michael | Administrateur | 4 Buxton Crescent SM3 9TP Cheam Surrey | British | 80557510001 | ||||||
| WILKINSON, Craig | Administrateur | 52 Meadway KT5 9RG Surbiton Surrey | British | 103169460001 | ||||||
| WOOD THORPE, Olivia | Administrateur | Wordsworth Road BN11 3JB Worthing 43a West Sussex England | United Kingdom | British | 116421060001 | |||||
| @UKPLC CLIENT DIRECTOR LTD | Administrateur désigné | 5, Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading | 900025720001 |
SAFRAN HOMES LTD a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Créé le 17 mai 2011 Livré le 20 mai 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 14 starrock road coulsdon together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage deed | Créé le 04 juin 2009 Livré le 23 juin 2009 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 27 and 31 hollymeoak road cousdon surrey, 20 sharrock road coulsdon surrey together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage deed | Créé le 26 mars 2008 Livré le 29 mars 2008 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a 16 + 18 + land to the rear of 20 starrock road, coulsdon, surrey t/nos P6832, SEL308349 SEL200539 (part). Together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 28 juin 2007 Livré le 29 juin 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 26 juin 2007 Livré le 06 juil. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Jays covert coulsdon lane chipstead surrey. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0