PEYTON & BYRNE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPEYTON & BYRNE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05325242
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PEYTON & BYRNE LIMITED ?

    • Agents impliqués dans la vente d'une variété de biens (46190) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe PEYTON & BYRNE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Deloitte
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PEYTON & BYRNE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PEYTON & BRYNE LIMITED01 avr. 200501 avr. 2005
    SOULREAPER LIMITED06 janv. 200506 janv. 2005

    Quels sont les derniers comptes de PEYTON & BYRNE LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2016
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2016
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour PEYTON & BYRNE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    18 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    17 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    43 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    10 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de 44 Wellington Street London WC2E 7BD à Deloitte Four Brindleyplace Birmingham B1 2HZ le 02 nov. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    46 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 29 mars 2015

    22 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Deeming le 09 mars 2016

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    24 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 mars 2016

    État du capital au 09 mars 2016

    • Capital: GBP 1.403
    SH01

    Inscription de la charge 053252420007, créée le 12 févr. 2016

    34 pagesMR01

    Résolutions

    Resolutions
    63 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    23 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2015

    État du capital au 15 juin 2015

    • Capital: GBP 1.437988
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de Sunley Tower the National Gallery Trafalgar Square London WC2N 5DN à 44 Wellington Street London WC2E 7BD le 11 juin 2015

    2 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Siobhan Helen Bridget Peyton le 19 mai 2015

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Caitriona Mary Peyton le 19 mai 2015

    3 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    22 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 130 Shaftesbury Avenue 2Nd Floor London W1D 5EU United Kingdom à Sunley Tower the National Gallery Trafalgar Square London WC2N 5DN le 18 août 2014

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Matthew Britton en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Deeming en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    État du capital après une attribution d'actions au 07 mars 2014

    • Capital: GBP 1.40
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    23 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de PEYTON & BYRNE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEYTON, Siobhan Helen Bridget
    Fellows Road
    NW3 3JH London
    Flat 1 122
    Secrétaire
    Fellows Road
    NW3 3JH London
    Flat 1 122
    IrishRestaurateur45610940004
    BREW, Alistair Jeremy
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Deloitte
    Administrateur
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Deloitte
    United KingdomBritishCompany Director167564750001
    DEEMING, Paul Jonathan
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Deloitte
    Administrateur
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Deloitte
    EnglandBritishDirector181849520001
    JOHNSON, Michael Andrew
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Deloitte
    Administrateur
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Deloitte
    United KingdomBritishCompany Director98243170001
    PEYTON, Caitriona Mary
    122 Fellows Road
    NW3 3JH London
    Flat 1
    United Kingdom
    Administrateur
    122 Fellows Road
    NW3 3JH London
    Flat 1
    United Kingdom
    EnglandIrishRestauranteur176603040002
    PEYTON, Oliver Peter Patrick
    30 Perryn Road
    W3 7NA London
    Administrateur
    30 Perryn Road
    W3 7NA London
    EnglandIrishRestaurateur51417690004
    PEYTON, Siobhan Helen
    Fellows Road
    NW3 3JH London
    Flat 1 122
    Administrateur
    Fellows Road
    NW3 3JH London
    Flat 1 122
    EnglandIrishRestaurateur45610940005
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    Secrétaire désigné
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    900023410001
    BRITTON, Matthew Victor
    Westville Road
    W12 9BB London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Westville Road
    W12 9BB London
    25
    United Kingdom
    Great BritainBritishAccountant176596240001
    PEYTON, Caitriona Mary
    Fellows Road
    NW3 3JH London
    Flat 1 122
    Administrateur
    Fellows Road
    NW3 3JH London
    Flat 1 122
    United KingdomIrishRestaurateur60003640001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    Administrateur désigné
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    900023400001

    PEYTON & BYRNE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 févr. 2016
    Livré le 02 mars 2016
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Business Growth Fund PLC
    Transactions
    • 02 mars 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 26 mars 2013
    Livré le 28 mars 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form MG01 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Barclays bank PLC re peyton & byrne limited business premium account ac/no 73380882.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 22 mars 2013
    Livré le 28 mars 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 23 mars 2012
    Livré le 29 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £300,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Olga Polizzi
    Transactions
    • 29 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 29 juil. 2009
    Livré le 30 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    £12,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £12,500.00 rent deposit plus accrued interest.
    Personnes ayant droit
    • The Wallace Collection and Hertford House Marketing Limited
    Transactions
    • 30 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 26 janv. 2009
    Livré le 12 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    £14,687.50 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company's interest in the account (as defiend in the rent deposit deed) and all money from time to time in the account or withdrawn from the account in accordance with the rent deposit deed to HS1 limited and security for the performance of the company's obligations under a lease of unit 11 st pancras station london and made between HS1 limited (1) and the company (2) and the rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • HS1 Limited
    Transactions
    • 12 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 nov. 2007
    Livré le 13 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £500,000 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge on book debts plant equipment goodwill and all other assets.
    Personnes ayant droit
    • Siobhan Helen Bridget Peyton
    Transactions
    • 13 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    PEYTON & BYRNE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 oct. 2016Administration started
    25 oct. 2017Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Robert James Harding
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0