STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED

STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05339907
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Autres installations en construction (43290) / Construction

    Où se situe STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite G2 Montpellier House
    Montpellier Drive
    GL50 1TY Cheltenham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED24 janv. 200524 janv. 2005

    Quels sont les derniers comptes de STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    25 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 sept. 2020

    21 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 sept. 2019

    30 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Unit 2 Doctors Lane Henley-in-Arden West Midlands B95 5AW à Suite G2 Montpellier House Montpellier Drive Cheltenham GL50 1TY le 05 oct. 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires

    8 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 20 sept. 2018

    LRESEX

    Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2017

    10 pagesAA

    Notification de Margaret Mills en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juin 2017

    2 pagesPSC01

    Cessation de Anthony William Mills en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juin 2017

    1 pagesPSC07

    Comptes modifiés avec exemption totale pour une petite société jusqu'au 30 avr. 2016

    7 pagesAAMD

    Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2016

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Philip Archer en tant que directeur le 19 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Steve Sullivan en tant qu'administrateur le 21 mars 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mars 2016

    État du capital au 31 mars 2016

    • Capital: GBP 17
    SH01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2015

    8 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2015

    État du capital au 27 janv. 2015

    • Capital: GBP 20
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2014

    8 pagesAA

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    8 pagesMR04

    Deuxième dépôt de TM01 précédemment soumis à Companies House

    4 pagesRP04
    Annotations
    DateAnnotation
    17 juin 2014SECOND FILED TM01 FOR ANTHONY MILLS

    Qui sont les dirigeants de STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MILLS, Margaret
    Orchard Rise
    B95 5FL Henley-In-Arden
    Mulberry House
    West Midlands
    England
    Secrétaire
    Orchard Rise
    B95 5FL Henley-In-Arden
    Mulberry House
    West Midlands
    England
    British103164170001
    SULLIVAN, Steve
    Montpellier Drive
    GL50 1TY Cheltenham
    Suite G2 Montpellier House
    Administrateur
    Montpellier Drive
    GL50 1TY Cheltenham
    Suite G2 Montpellier House
    EnglandBritishDirector211616090001
    WAYNE, Harold
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire désigné
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    British900005490001
    ARCHER, Philip
    Doctors Lane
    B95 5AW Henley-In-Arden
    Unit 2
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Doctors Lane
    B95 5AW Henley-In-Arden
    Unit 2
    West Midlands
    England
    EnglandBritishCompany Director184815330001
    DICKINSON, Kevin Charles
    10 Sevincott Close
    CV37 9JX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    10 Sevincott Close
    CV37 9JX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishContract Manager105871870001
    MILLS, Anthony William
    Orchard Rise
    B95 5FL Henley-In-Arden
    Mulberry House
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Orchard Rise
    B95 5FL Henley-In-Arden
    Mulberry House
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director103163910003
    WAYNE, Yvonne
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish900005480001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Margaret Mills
    Montpellier Drive
    GL50 1TY Cheltenham
    Suite G2 Montpellier House
    30 juin 2017
    Montpellier Drive
    GL50 1TY Cheltenham
    Suite G2 Montpellier House
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Mr Anthony William Mills
    Doctors Lane
    B95 5AW Henley-In-Arden
    Unit 2
    West Midlands
    30 juin 2016
    Doctors Lane
    B95 5AW Henley-In-Arden
    Unit 2
    West Midlands
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 févr. 2014
    Livré le 20 févr. 2014
    En cours
    Brève description
    F/H property known on land as warehouse and store dotors lane henley-in-arden t/no. WK321788. Notification of addition to or amendment of charge.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 20 févr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 25 sept. 2013
    Livré le 03 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 03 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Mortgage deed
    Créé le 06 juin 2012
    Livré le 08 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property being unit 1 & 2 doctors lane honley in arden together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 mai 2012
    Livré le 19 mai 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 21 déc. 2011
    Livré le 22 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H warehouse & store, doctors lane, henley-in-arden, warwickshire t/no WK321788; proceeds of sale, all buildings and fixtures (including trade fixtures), all rights, easements and privileges.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 09 oct. 2009
    Livré le 14 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance LTD
    Transactions
    • 14 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 sept. 2006
    Livré le 20 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    STANDARD ONE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 août 2021Dissolved on
    20 sept. 2018Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael Patrick Durkan
    Suite G2 Montpellier House
    Montpellier Drive
    GL50 1TY Cheltenham
    practitioner
    Suite G2 Montpellier House
    Montpellier Drive
    GL50 1TY Cheltenham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0