EQUINITI X2 CAP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEQUINITI X2 CAP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05347975
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EQUINITI X2 CAP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe EQUINITI X2 CAP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EQUINITI X2 CAP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    XAFINITY CAPITAL LIMITED29 août 200829 août 2008
    XAFINITY SOLUTIONS LIMITED19 janv. 200719 janv. 2007
    XAFINITY CONSULTING LIMITED11 juil. 200511 juil. 2005
    CHANTBRIGHT LIMITED31 janv. 200531 janv. 2005

    Quels sont les derniers comptes de EQUINITI X2 CAP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EQUINITI X2 CAP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour EQUINITI X2 CAP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martyn John Hindley le 03 déc. 2012

    2 pagesCH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Changement d'adresse du siège social de Sutherland House Russell Way Crawley West Sussex RH10 1UH le 28 mai 2014

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Robert Bloor en tant qu'administrateur le 14 févr. 2014

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 févr. 2014

    État du capital au 07 févr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Nomination de David Venus & Company Llp en tant que secrétaire le 20 sept. 2013

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Wayne Andrew Story en tant que directeur le 31 oct. 2013

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Kenneth Swabey en tant que secrétaire le 20 sept. 2013

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    17 pagesAA

    Nomination de Peter Kenneth Swabey en tant que secrétaire le 01 août 2013

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Sharon Anne Atherton en tant que secrétaire le 31 juil. 2013

    1 pagesTM02

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    legacy

    3 pagesSH20

    legacy

    3 pagesCAP-SS

    État du capital au 18 juin 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account reduced 17/06/2013
    RES13

    État du capital après une attribution d'actions au 18 juin 2013

    • Capital: GBP 2
    5 pagesSH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed xafinity capital LIMITED\certificate issued on 28/02/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name28 févr. 2013

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Robert Bloor en tant que directeur le 03 déc. 2012

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de EQUINITI X2 CAP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVID VENUS & COMPANY LLP
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleCOMPANIES ACT 2006
    Numéro d'enregistrementOC309455
    131429630001
    BLOOR, Robert David
    Russell Way
    Crawley
    RH10 1UH West Sussex
    Sutherland House
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    Russell Way
    Crawley
    RH10 1UH West Sussex
    Sutherland House
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant169661800001
    HINDLEY, Martyn John
    Russell Way
    RH10 1UH Crawley
    Sutherland House
    West Sussex
    England
    Administrateur
    Russell Way
    RH10 1UH Crawley
    Sutherland House
    West Sussex
    England
    EnglandBritishFinance Director134332760002
    ATHERTON, Sharon Anne
    Loddon House
    Old House Lane
    TN22 5TN Ridgewood Uckfield
    East Sussex
    Secrétaire
    Loddon House
    Old House Lane
    TN22 5TN Ridgewood Uckfield
    East Sussex
    BritishLegal Adviser31847070001
    SALTER, James Anthony
    1 Lightfoot Grove
    RG21 3HU Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    1 Lightfoot Grove
    RG21 3HU Basingstoke
    Hampshire
    BritishAccountant106647240001
    STAHELIN, Peter Charles
    112 Ember Lane
    KT10 8EL Esher
    Surrey
    Secrétaire
    112 Ember Lane
    KT10 8EL Esher
    Surrey
    British56442720001
    SWABEY, Peter Kenneth
    Sutherland House
    Russell Way
    RH10 1UH Crawley
    West Sussex
    Secrétaire
    Sutherland House
    Russell Way
    RH10 1UH Crawley
    West Sussex
    180479300001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BELKIN, Jeffrey Philip
    10a Sherriff Road
    NW6 2AU West Hampstead
    London
    Administrateur
    10a Sherriff Road
    NW6 2AU West Hampstead
    London
    United KingdomBritishAccountant79906460001
    BLOOR, Robert David
    42 - 62
    Greyfriars Road
    RG1 1NN Reading
    Xafinity House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    42 - 62
    Greyfriars Road
    RG1 1NN Reading
    Xafinity House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant169661800001
    JONES, Frank Stevenson
    37 Middlefield Lane
    Hagley
    DY9 0PY Stourbridge
    Administrateur
    37 Middlefield Lane
    Hagley
    DY9 0PY Stourbridge
    United KingdomBritishCompany Director11021040001
    LEBUS, Timothy Andrew
    70 Ellerby Street
    SW6 6EZ London
    Administrateur
    70 Ellerby Street
    SW6 6EZ London
    BritishBanker6855830001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritishSolicitor147682410001
    MARNOCH, Alasdair
    Sutherland House
    Russell Way
    RH10 1UH Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    Sutherland House
    Russell Way
    RH10 1UH Crawley
    West Sussex
    UnitedkingdomBritishDirector81076080003
    MEADES, Derek Leslie
    8 Wellswood
    London Road
    SL5 7EA Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    8 Wellswood
    London Road
    SL5 7EA Ascot
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant105163650001
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Administrateur désigné
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    ROBINSON, Timothy Michael
    Wells Farmhouse
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Wells Farmhouse
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director154155330001
    SCOTT, Thomas James Buchan
    Almack House
    28 King Street
    SW1Y 6XA London
    Administrateur
    Almack House
    28 King Street
    SW1Y 6XA London
    BritishCommercial Director92125880001
    STORY, Wayne Andrew
    Spencer Road
    BN99 6DA Lancing
    Aspect House
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Spencer Road
    BN99 6DA Lancing
    Aspect House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director136069640001
    TAYLOR, Peter Lance
    Almack House
    28 King Street
    SW1Y 6XA London
    Administrateur
    Almack House
    28 King Street
    SW1Y 6XA London
    BritishBanker92125620001

    EQUINITI X2 CAP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 27 janv. 2010
    Livré le 01 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating security document
    Créé le 04 avr. 2008
    Livré le 17 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any senior finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Calyon, as Security Trustee for the Benefit of the Senior Finance Parties
    Transactions
    • 17 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 02 mai 2007
    Livré le 09 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any senior finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Calyon as Security Trustee for the Benefit of the Senior Finance Parties
    Transactions
    • 09 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 08 avr. 2005
    Livré le 18 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any senior finance party,to any mezzanine finance party or to any pik noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Calyon as Security Trustee for the Benefit of the Senior Finance Parties,the Mezzanine Financeparties and the Pik Noteholders
    Transactions
    • 18 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0