VGH ACQUISITIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVGH ACQUISITIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05361760
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VGH ACQUISITIONS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe VGH ACQUISITIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de VGH ACQUISITIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour VGH ACQUISITIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour VGH ACQUISITIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Paul Martin Wright en tant que secrétaire le 10 juin 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Matthew Miller en tant que secrétaire le 10 juin 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Paul Martin Wright en tant qu'administrateur le 10 juin 2015

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 28 avr. 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 27 avr. 2015

    • Capital: GBP 33,159,572
    3 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mars 2015

    État du capital au 03 mars 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 mai 2014

    État du capital au 01 mai 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Adrian Lamb en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Adrian Lamb en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Matthew Miller en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Adrian Lamb en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Adrian Lamb en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    8 pagesAA

    Nomination de Mr Adrian Lamb en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Nomination de Mr Adrian Geoffrey Lamb en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de VGH ACQUISITIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WRIGHT, Paul Martin
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    Secrétaire
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    198407240001
    MILLER, Matthew Kerr
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    Administrateur
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    United KingdomBritishDirector179720330001
    WRIGHT, Paul Martin
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    Administrateur
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    United KingdomBritishDirector189121640001
    ATTRILL, Christopher Richard
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    Secrétaire
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    BritishFinance Director93024670001
    ATTRILL, Christopher Richard
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    Secrétaire
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    BritishDirector93024670001
    FITZGERALD, David Sean
    1 Greenmount Gardens
    Greenmount
    BL8 4HN Bury
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Greenmount Gardens
    Greenmount
    BL8 4HN Bury
    Lancashire
    BritishSolicitor61196400001
    LAMB, Adrian
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    Secrétaire
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    179723740001
    MILLER, Matthew
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    Secrétaire
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    186739250001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secrétaire
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    ATTRILL, Christopher Richard
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    Administrateur
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    EnglandBritishDirector93024670001
    HASLAM, Linda Karen
    Chapel House Barn
    High Street
    BL7 0EW Turton
    Lancashire
    Administrateur
    Chapel House Barn
    High Street
    BL7 0EW Turton
    Lancashire
    EnglandBritishDirector126428360001
    LAMB, Adrian Geoffrey
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    Administrateur
    Folds Road
    Bolton
    BL1 2TX Lancashire
    EnglandBritishDirector41255800002
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite 50 Victoria Embankment
    Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Administrateur
    Carmelite 50 Victoria Embankment
    Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    39090660001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y 0DX Blackfriars
    London
    Administrateur
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y 0DX Blackfriars
    London
    41864110001

    VGH ACQUISITIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 févr. 2008
    Livré le 08 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the compant to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 08 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 juil. 2007
    Livré le 23 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties and the mezzanine finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 23 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2005
    Livré le 09 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and vgh aquisitons (holdings) limited to the chargee (as security trustee) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 09 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0