CHEVIOT TRUSTEES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CHEVIOT TRUSTEES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 05396879 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CHEVIOT TRUSTEES LIMITED ?
| Adresse du siège social | S7 Launchpad Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CHEVIOT TRUSTEES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CHEVIOT TRUSTEES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 mars 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 31 mars 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 mars 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CHEVIOT TRUSTEES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 17 mars 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Kingswood House, 58 - 64 Baxter Avenue Southend-on-Sea SS2 6BG à S7 Launchpad Cherry Orchard Way Rochford SS4 1YH le 16 sept. 2025 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de Ian Thompson Gault en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juin 2024 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Maralyn Ann Thomas en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2024 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Maralyn Ann Thomas en tant que directeur le 01 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2023 | 19 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Thompson Gault en tant que directeur le 30 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Statuts | 12 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 16 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022 | 19 pages | AA | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Origin Two 106 High Street Crawley West Sussex RH10 1BF England à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2021 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mars 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de Philip Tranter en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 févr. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020 | 18 pages | AA | ||||||||||
Notification de Stephen Jones en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 avr. 2021 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Jones en tant qu'administrateur le 14 avr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CHEVIOT TRUSTEES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKINNON, Elspeth | Secrétaire | 2 Longmead Close Shenfield CM15 8DT Brentwood Essex | British | 37308740001 | ||||||
| ELLIOTT-SMITH, Diane Margaret | Administrateur | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | United Kingdom | British | 254115080001 | |||||
| JONES, Stephen | Administrateur | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | England | British | 273970590001 | |||||
| KIDD, Gerald Edward | Administrateur | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | United Kingdom | British | 96133500001 | |||||
| LONGMORE, Frances Lesley | Administrateur | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | England | British | 254115350001 | |||||
| MCKINNON, Elspeth | Administrateur | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | United Kingdom | British | 37308740001 | |||||
| MORRIS, Derek James, Sir | Administrateur | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | 228531670001 | |||||
| ORTON, Giles Anthony Christopher | Administrateur | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | United Kingdom | British | 84820160001 | |||||
| POORE, Martin | Administrateur | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | United Kingdom | British | 187498090002 | |||||
| BERRY, John Joseph | Administrateur | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | United Kingdom | British | 34030020002 | |||||
| BLABER, Michael Edward | Administrateur | Wolmers Hey Great Waltham CM3 1DA Chelmsford 32 Essex | United Kingdom | British | 130248060001 | |||||
| BRAITHWAITE, Neil Elliott | Administrateur | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | United Kingdom | British | 33239050003 | |||||
| BYASS, Kenneth Peter | Administrateur | Tower House 4, School Street LE7 7RA Rothley Leicestershire | England | British | 109809760002 | |||||
| CORNWELL, John Rainsford | Administrateur | Cheviot House 70 Baxter Avenue SS2 6JA Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | 150497440001 | |||||
| DUNGAY, John Alan | Administrateur | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | United Kingdom | British | 105368670001 | |||||
| GAULT, Ian Thompson | Administrateur | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | United Kingdom | British | 15764300004 | |||||
| HALL, Robert Ponton | Administrateur | Roman Way 42a King Street West Deeping PE6 9HP Peterborough Cambridgeshire | England | British | 26088400001 | |||||
| HUGHES, Paul John | Administrateur | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | England | British | 5389800001 | |||||
| HUNT, Sarah Alison Holly | Administrateur | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | England | British | 105368380001 | |||||
| JENKINS, Martin James Harper | Administrateur | St Ann's Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 80930120002 | ||||||
| JENKINS, Martin James Harper | Administrateur | 2 Exelby Close Whitebridge Park NE3 5LG Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | 80930120001 | ||||||
| LODGE, Sophia Ann Marie | Administrateur | 82 Birchen Grove NW9 8OA London | British | 114364820001 | ||||||
| MAKIN, Susan Ann | Administrateur | 129 Roman Road Failsworth M35 9JY Manchester Lancashire | British | 105368270001 | ||||||
| MCCONNELL, Denise | Administrateur | Newfields Gatebridge Galphay HG4 3NT Ripon | England | British | 101143750001 | |||||
| MITCHELL, Geoffrey Ian | Administrateur | 17a Rectory Park EX39 3AJ Bideford Devon | British | 105368840001 | ||||||
| PURDY, Frank | Administrateur | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | United Kingdom | British | 81538990001 | |||||
| RIMMINGTON, Richard Leon Edgar | Administrateur | 27 Cleveland Road SK4 4BS Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 43029120001 | |||||
| SMITH, Vineeta | Administrateur | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | England | British | 135234350003 | |||||
| THOMAS, Maralyn Ann | Administrateur | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | United Kingdom | British | 92105560003 | |||||
| TROTT, Linky Dorothea | Administrateur | 38 Randolph Street NW1 0SR London | British | 105368780001 | ||||||
| WEEKS, Jeremy William Robert | Administrateur | 26 Stanier Way Hedge End SO30 2XF Southampton Hampshire | British | 44813190002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHEVIOT TRUSTEES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Stephen Jones | 14 avr. 2021 | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Ms Frances Lesley Longmore | 01 janv. 2019 | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Diane Margaret Elliott-Smith | 01 janv. 2019 | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Giles Anthony Christopher Orton | 12 nov. 2018 | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Giles Anthony Christopher Orton | 27 sept. 2018 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Maralyn Ann Thomas | 26 mai 2017 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Sir Derek James Morris | 01 avr. 2017 | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | Non |
Nationalité: United Kingdom Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Ian Thompson Gault | 18 avr. 2016 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr John Joseph Berry | 18 avr. 2016 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Vineeta Smith | 18 avr. 2016 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Neil Elliott Braithwaite | 18 avr. 2016 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr John Alan Dungay | 18 avr. 2016 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Paul John Hughes | 18 avr. 2016 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Frank Purdy | 18 avr. 2016 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Sarah Alison Holly Hunt | 18 avr. 2016 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Robert Ponton Hall | 18 avr. 2016 | Baxter Avenue SS2 6BG Southend-On-Sea Kingswood House, 58 - 64 | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Martin Poore | 18 avr. 2016 | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Gerald Edward Kidd | 18 avr. 2016 | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Ms Elspeth Mckinnon | 18 avr. 2016 | Cherry Orchard Way SS4 1YH Rochford S7 Launchpad United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Philip Tranter | 06 avr. 2016 | Cockpit Lane Sandiway CW8 2DT Northwich Praecon Limited Cheshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0