ICA MANAGED PRINT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéICA MANAGED PRINT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05407869
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ICA MANAGED PRINT LIMITED ?

    • Réparation d'autres équipements (33190) / Industries manufacturières

    Où se situe ICA MANAGED PRINT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    20 Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ICA MANAGED PRINT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ICA DIGITAL LTD30 mars 200530 mars 2005

    Quels sont les derniers comptes de ICA MANAGED PRINT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour ICA MANAGED PRINT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Satisfaction de la charge 054078690007 en totalité

    1 pagesMR04

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 14 mars 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Inscription de la charge 054078690007, créée le 22 févr. 2018

    29 pagesMR01

    Nomination de Mr David Campbell en tant qu'administrateur le 22 févr. 2018

    2 pagesAP01

    legacy

    9 pagesRP04CS01

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2016

    23 pagesRP04AR01

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2015

    23 pagesRP04AR01

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2014

    23 pagesRP04AR01

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2013

    23 pagesRP04AR01

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2011

    23 pagesRP04AR01

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2010

    23 pagesRP04AR01

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2012

    23 pagesRP04AR01

    Cessation de la nomination de Simon Whapshott en tant que directeur le 22 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mark Garius en tant qu'administrateur le 22 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de , Woodbridge House, Chapel Road, Smallfield, Surrey, RH6 9NW à 20 Trafalgar Way Bar Hill Cambridge CB23 8SQ le 23 févr. 2018

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Bryan Lloyd Taylor en tant que directeur le 22 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Mark Wardle en tant que directeur le 22 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon Whapshott en tant que secrétaire le 22 févr. 2018

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de James Alan Browne en tant que directeur le 22 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Bryan Lloyd Taylor en tant que directeur le 22 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert John Price en tant que directeur le 22 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de ICA MANAGED PRINT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAMPBELL, David
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    Administrateur
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    United KingdomBritishDirector177927020001
    GARIUS, Mark
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    Administrateur
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    United KingdomSwiss,BritishDirector67448210001
    DWYER, Daniel John
    Goldfinch Close
    Chelsfield
    BR6 6NF Orpington
    14
    Kent
    Secrétaire
    Goldfinch Close
    Chelsfield
    BR6 6NF Orpington
    14
    Kent
    British112335920001
    FRASER, Rita
    22 Park Hill Road
    SM6 0SB Wallington
    Surrey
    Secrétaire
    22 Park Hill Road
    SM6 0SB Wallington
    Surrey
    BritishDirector70582880001
    WHAPSHOTT, Simon
    c/o C/O Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    Secrétaire
    c/o C/O Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    BritishDirector104631160002
    BROWNE, James Alan
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    Administrateur
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    EnglandBritishSales Director221298930001
    DWYER, Daniel James
    Clovers End
    Patcham
    BN1 8PJ Brighton
    2
    East Sussex
    Administrateur
    Clovers End
    Patcham
    BN1 8PJ Brighton
    2
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Registration Agent86094440001
    FITZGERALD, Michael James
    2 Redwood Mount
    Beech Road
    RH2 9NB Reigate
    Surrey
    Administrateur
    2 Redwood Mount
    Beech Road
    RH2 9NB Reigate
    Surrey
    BritishCo Director37173650002
    FRASER, Rita
    22 Park Hill Road
    SM6 0SB Wallington
    Surrey
    Administrateur
    22 Park Hill Road
    SM6 0SB Wallington
    Surrey
    BritishDirector70582880001
    HALLISSEY, Steven Peter
    Chequers Avenue
    HP11 1GD High Wycombe
    24
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Chequers Avenue
    HP11 1GD High Wycombe
    24
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishExecutive Chairman189881910001
    HEALY, Russell
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    Administrateur
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    EnglandBritishDirector194872660001
    NASH, Andrew John
    Cheddon Corner
    Cheddon Fitzpaine
    TA2 8LB Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Cheddon Corner
    Cheddon Fitzpaine
    TA2 8LB Taunton
    Somerset
    EnglandBritishDirector53544690001
    O'CONNOR, Mark Philip
    57 North Worple Way
    Mortlake
    SW14 8PS London
    Administrateur
    57 North Worple Way
    Mortlake
    SW14 8PS London
    United KingdomIrishCommercial Director110228770001
    POWAR, Sonita Jatinder Kaur
    Worlds End Lane
    BR6 6AT Chelsfield
    201
    Kent
    Administrateur
    Worlds End Lane
    BR6 6AT Chelsfield
    201
    Kent
    UkBritishVenture Capitalist136721480001
    PRICE, Robert John
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    Administrateur
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    EnglandBritishCommercial Director104631180002
    RAWSON, Kevin Andrew
    Southwood
    Waller Lane
    CR3 5EA Caterham
    Surrey
    Administrateur
    Southwood
    Waller Lane
    CR3 5EA Caterham
    Surrey
    United KingdomBritishCo Director37173660003
    SHANNON, Andrew James Mciver
    Woodbridge House
    Chapel Road
    RH6 9NW Smallfield
    Surrey
    Administrateur
    Woodbridge House
    Chapel Road
    RH6 9NW Smallfield
    Surrey
    EnglandBritishInvestment Management162601010001
    TAYLOR, Bryan Lloyd
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    Administrateur
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    EnglandBritishNon-Executive Chairman71356520003
    WARDLE, Christopher Mark
    Foresight Group
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    Administrateur
    Foresight Group
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    EnglandBritishInvestment Director229534990001
    WHAPSHOTT, Simon
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    Administrateur
    c/o Ica Limited
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    England
    EnglandBritishCompany Director104631160003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ICA MANAGED PRINT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    Surrey
    England
    14 mars 2017
    Chapel Road
    Smallfield
    RH6 9NW Horley
    Woodbridge House
    Surrey
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06766039
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ICA MANAGED PRINT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 févr. 2018
    Livré le 01 mars 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    By way of fixed charge all right, title, estate and other interests of the company in all freehold or leasehold property now or at any time vested in or held by or on behalf of the company and including all rights attached or appurtenant to it and all buildings, erections, fixtures and fittings.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 01 mars 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 févr. 2009
    Livré le 05 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other investors or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Robert John Price
    Transactions
    • 05 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 févr. 2009
    Livré le 05 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other investors or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rita Fraser
    Transactions
    • 05 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 févr. 2009
    Livré le 28 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the principal and/or the company to the chargee and/or any of the other investors on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Foresight 2 Vct PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 28 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 févr. 2009
    Livré le 25 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 mai 2005
    Livré le 03 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Toshiba Tec UK Imaging Systems Limited
    Transactions
    • 03 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 mai 2005
    Livré le 27 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 27 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0