ICA MANAGED PRINT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ICA MANAGED PRINT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05407869 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ICA MANAGED PRINT LIMITED ?
Adresse du siège social | 20 Trafalgar Way Bar Hill CB23 8SQ Cambridge England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ICA MANAGED PRINT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 janv. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour ICA MANAGED PRINT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Satisfaction de la charge 054078690007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 mars 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Inscription de la charge 054078690007, créée le 22 févr. 2018 | 29 pages | MR01 | ||
Nomination de Mr David Campbell en tant qu'administrateur le 22 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
legacy | 9 pages | RP04CS01 | ||
Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2016 | 23 pages | RP04AR01 | ||
Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2015 | 23 pages | RP04AR01 | ||
Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2014 | 23 pages | RP04AR01 | ||
Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2013 | 23 pages | RP04AR01 | ||
Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2011 | 23 pages | RP04AR01 | ||
Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2010 | 23 pages | RP04AR01 | ||
Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 30 mars 2012 | 23 pages | RP04AR01 | ||
Cessation de la nomination de Simon Whapshott en tant que directeur le 22 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mark Garius en tant qu'administrateur le 22 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Changement d'adresse du siège social de , Woodbridge House, Chapel Road, Smallfield, Surrey, RH6 9NW à 20 Trafalgar Way Bar Hill Cambridge CB23 8SQ le 23 févr. 2018 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Bryan Lloyd Taylor en tant que directeur le 22 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Christopher Mark Wardle en tant que directeur le 22 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Simon Whapshott en tant que secrétaire le 22 févr. 2018 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de James Alan Browne en tant que directeur le 22 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Bryan Lloyd Taylor en tant que directeur le 22 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Robert John Price en tant que directeur le 22 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Qui sont les dirigeants de ICA MANAGED PRINT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPBELL, David | Administrateur | Trafalgar Way Bar Hill CB23 8SQ Cambridge 20 England | United Kingdom | British | Director | 177927020001 | ||||
GARIUS, Mark | Administrateur | Trafalgar Way Bar Hill CB23 8SQ Cambridge 20 England | United Kingdom | Swiss,British | Director | 67448210001 | ||||
DWYER, Daniel John | Secrétaire | Goldfinch Close Chelsfield BR6 6NF Orpington 14 Kent | British | 112335920001 | ||||||
FRASER, Rita | Secrétaire | 22 Park Hill Road SM6 0SB Wallington Surrey | British | Director | 70582880001 | |||||
WHAPSHOTT, Simon | Secrétaire | c/o C/O Ica Limited Chapel Road Smallfield RH6 9NW Horley Woodbridge House England | British | Director | 104631160002 | |||||
BROWNE, James Alan | Administrateur | c/o Ica Limited Chapel Road Smallfield RH6 9NW Horley Woodbridge House England | England | British | Sales Director | 221298930001 | ||||
DWYER, Daniel James | Administrateur | Clovers End Patcham BN1 8PJ Brighton 2 East Sussex | United Kingdom | British | Company Registration Agent | 86094440001 | ||||
FITZGERALD, Michael James | Administrateur | 2 Redwood Mount Beech Road RH2 9NB Reigate Surrey | British | Co Director | 37173650002 | |||||
FRASER, Rita | Administrateur | 22 Park Hill Road SM6 0SB Wallington Surrey | British | Director | 70582880001 | |||||
HALLISSEY, Steven Peter | Administrateur | Chequers Avenue HP11 1GD High Wycombe 24 Buckinghamshire England | United Kingdom | British | Executive Chairman | 189881910001 | ||||
HEALY, Russell | Administrateur | London Bridge Street SE1 9SG London The Shard England | England | British | Director | 194872660001 | ||||
NASH, Andrew John | Administrateur | Cheddon Corner Cheddon Fitzpaine TA2 8LB Taunton Somerset | England | British | Director | 53544690001 | ||||
O'CONNOR, Mark Philip | Administrateur | 57 North Worple Way Mortlake SW14 8PS London | United Kingdom | Irish | Commercial Director | 110228770001 | ||||
POWAR, Sonita Jatinder Kaur | Administrateur | Worlds End Lane BR6 6AT Chelsfield 201 Kent | Uk | British | Venture Capitalist | 136721480001 | ||||
PRICE, Robert John | Administrateur | c/o Ica Limited Chapel Road Smallfield RH6 9NW Horley Woodbridge House England | England | British | Commercial Director | 104631180002 | ||||
RAWSON, Kevin Andrew | Administrateur | Southwood Waller Lane CR3 5EA Caterham Surrey | United Kingdom | British | Co Director | 37173660003 | ||||
SHANNON, Andrew James Mciver | Administrateur | Woodbridge House Chapel Road RH6 9NW Smallfield Surrey | England | British | Investment Management | 162601010001 | ||||
TAYLOR, Bryan Lloyd | Administrateur | c/o Ica Limited Chapel Road Smallfield RH6 9NW Horley Woodbridge House England | England | British | Non-Executive Chairman | 71356520003 | ||||
WARDLE, Christopher Mark | Administrateur | Foresight Group London Bridge Street SE1 9SG London The Shard England | England | British | Investment Director | 229534990001 | ||||
WHAPSHOTT, Simon | Administrateur | c/o Ica Limited Chapel Road Smallfield RH6 9NW Horley Woodbridge House England | England | British | Company Director | 104631160003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ICA MANAGED PRINT LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ica Group Limited | 14 mars 2017 | Chapel Road Smallfield RH6 9NW Horley Woodbridge House Surrey England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
ICA MANAGED PRINT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 22 févr. 2018 Livré le 01 mars 2018 | Totalement satisfaite | ||
Brève description By way of fixed charge all right, title, estate and other interests of the company in all freehold or leasehold property now or at any time vested in or held by or on behalf of the company and including all rights attached or appurtenant to it and all buildings, erections, fixtures and fittings. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 20 févr. 2009 Livré le 05 mars 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other investors or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 20 févr. 2009 Livré le 05 mars 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other investors or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 20 févr. 2009 Livré le 28 févr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the principal and/or the company to the chargee and/or any of the other investors on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 févr. 2009 Livré le 25 févr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 mai 2005 Livré le 03 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 mai 2005 Livré le 27 mai 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0