LINDLEY CATERING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLINDLEY CATERING LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05416831
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LINDLEY CATERING LIMITED ?

    • Activités de restauration événementielle (56210) / Hébergement et restauration
    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LINDLEY CATERING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LINDLEY CATERING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LINDLEY CATERING HOLDINGS LIMITED29 juin 200529 juin 2005
    BROOMCO (3779) LIMITED07 avr. 200507 avr. 2005

    Quels sont les derniers comptes de LINDLEY CATERING LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 août 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 mai 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour LINDLEY CATERING LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au29 juil. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation12 août 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au29 juil. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour LINDLEY CATERING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Angelo Piccirillo en tant que directeur le 19 mars 2026

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 août 2024

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Sean Michael Haley en tant que directeur le 31 déc. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2023

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Miss Claire Louise Morris en tant qu'administrateur le 18 juin 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Rebecca Kane Burton en tant que directeur le 30 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2022

    13 pagesAA

    Nomination de Mrs Rebecca Kane Burton en tant qu'administrateur le 14 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Susanna Marion Kitcher en tant que directeur le 14 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 août 2021

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ms Susanna Marion Kitcher en tant qu'administrateur le 02 févr. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christopher John Bray en tant que directeur le 17 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 054168310004 en totalité

    1 pagesMR04

    État du capital après une attribution d'actions au 28 janv. 2021

    • Capital: GBP 24,686,644.9
    4 pagesSH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2020

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2019

    11 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 août 2018

    18 pagesAA

    Nomination de Mrs Jean Mary Renton en tant qu'administrateur le 01 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Laurent Paul Joseph Arnaudo en tant que directeur le 01 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de LINDLEY CATERING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SODEXO CORPORATE SERVICES (NO.2) LIMITED
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    Secrétaire
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement3025574
    119601670002
    MORRIS, Claire Louise
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    Administrateur
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    EnglandBritish324516900001
    RENTON, Jean Mary
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    Administrateur
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    United KingdomBritish194625390001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    Secrétaire
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    167876840001
    MCCRINDLE, Alexander Campbell
    Brambles 3 The Forge
    Lower Stanton
    SN14 6RN St Quinton
    The
    Wiltshire
    Secrétaire
    Brambles 3 The Forge
    Lower Stanton
    SN14 6RN St Quinton
    The
    Wiltshire
    British1866250004
    WRIGHT, James Philip
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    Secrétaire
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    186825030001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    ARNAUDO, Laurent Paul Joseph
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    Administrateur
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    EnglandFrench210398050001
    BIFFEN, Paul Robert
    71 Northfield Road
    Sherfield On Loddon
    RG27 0DS Hook
    Hampshire
    Administrateur
    71 Northfield Road
    Sherfield On Loddon
    RG27 0DS Hook
    Hampshire
    United KingdomBritish48795270003
    BRAY, Christopher John
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    Administrateur
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    United KingdomBritish203694150001
    DALY, Ian
    The Dower House
    5 The Old Street
    KT22 9QL Fetcham
    Surrey
    Administrateur
    The Dower House
    5 The Old Street
    KT22 9QL Fetcham
    Surrey
    United KingdomBritish108661540001
    DISHINGTON, Adrian Robert
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    Administrateur
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    EnglandBritish187014060001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    Administrateur
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    United KingdomBritish91011320001
    ELLIOTT, Adam
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    Administrateur
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    United KingdomBritish207675710001
    HAGUE, Desmond Gerard
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    Administrateur
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    UsaAmerican186761700001
    HALEY, Sean Michael
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    Administrateur
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    EnglandBritish165657120001
    HAYDEN, Andrew Charles George
    Boughton Colemers
    Sophurst Lane Matfield
    TN12 7LH Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Boughton Colemers
    Sophurst Lane Matfield
    TN12 7LH Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish74179260004
    HEATHCOTE, Paul
    104/106 Higher Road
    Longridge
    PR3 3SX Preston
    Longridge Restaurant
    Lancs
    United Kingdom
    Administrateur
    104/106 Higher Road
    Longridge
    PR3 3SX Preston
    Longridge Restaurant
    Lancs
    United Kingdom
    United KingdomBritish48339040002
    HITCHCOCK, Simon
    37 Mount Pleasant Drive
    DE56 2PQ Belper
    Derbyshire
    Administrateur
    37 Mount Pleasant Drive
    DE56 2PQ Belper
    Derbyshire
    British93818430001
    HULME, David Harold
    Church View
    4 Lower Penkridge Road
    ST17 0RJ Acton
    Staffordshire
    Administrateur
    Church View
    4 Lower Penkridge Road
    ST17 0RJ Acton
    Staffordshire
    EnglandBritish106358590001
    KANE BURTON, Rebecca
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    Administrateur
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    EnglandBritish248089450001
    KING, Keith Baxter Willson
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    Administrateur
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    UsaAmerican186761800001
    KITCHER, Susanna Marion
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    Administrateur
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    EnglandBritish292449060001
    MCCRINDLE, Alexander Campbell
    Brambles 3 The Forge
    Lower Stanton
    SN14 6RN St Quinton
    The
    Wiltshire
    Administrateur
    Brambles 3 The Forge
    Lower Stanton
    SN14 6RN St Quinton
    The
    Wiltshire
    United KingdomBritish1866250004
    MONAVAR, Hadi K.
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    Administrateur
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    United StatesAmerican186761660001
    NEEDLEY, Michael
    The Mellor Building
    Queens Road
    ST4 7TR Penkhul
    Stoke On Trent
    Administrateur
    The Mellor Building
    Queens Road
    ST4 7TR Penkhul
    Stoke On Trent
    EnglandBritish75556820002
    PICCIRILLO, Angelo
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    Administrateur
    Southampton Row
    WC1B 5HA London
    One
    England
    FranceItalian250022940001
    STERN, Robert
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    Administrateur
    Town Road Business Quarter
    Hanley
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    United StatesAmerican211265170001
    VERROS, Chris Steven
    Atlantic Street
    Stamford
    2187
    Connecticut
    United States
    Administrateur
    Atlantic Street
    Stamford
    2187
    Connecticut
    United States
    United StatesAmerican192667970001
    DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610002
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LINDLEY CATERING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Centerplate Europe Limited
    Town Road Business Quarter
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    30 juin 2016
    Town Road Business Quarter
    ST1 2QA Stoke-On-Trent
    Mitchell House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland & Wales - Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House - England & Wales
    Numéro d'enregistrement08458339
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0