BALDERTON BANBURY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BALDERTON BANBURY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05429527 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BALDERTON BANBURY LIMITED ?
| Adresse du siège social | 105 Wigmore Street W1U 1QY London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BALDERTON BANBURY LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BALDERTON BANBURY LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour BALDERTON BANBURY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Richard Bruce Mitchell le 31 déc. 2013 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew John Pettit le 01 sept. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 20 Balderton Street London W1K 6TL à 105 Wigmore Street London W1U 1QY le 12 sept. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | MG01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 14 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2009 | 13 pages | AA | ||||||||||
legacy | 8 pages | MG01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 58 Davies Street London W1K 5JF* le 28 juil. 2010 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed kenmore banbury LIMITED\certificate issued on 21/07/10 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Nomination de William James Killick en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Lee Maytum en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Cairns en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Henry James Angell-James en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BALDERTON BANBURY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITCHELL, Richard Bruce | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QY London 105 England | British | 152314650001 | ||||||
| ANGELL-JAMES, Henry James | Administrateur | 26-28 Ludgate Hill B3 1DX Birmingham Victory House | United Kingdom | British | 152314900001 | |||||
| KILLICK, William James | Administrateur | Balderton Street W1K 6TL London 20 | Uk | British | 152751860001 | |||||
| MAYTUM, Lee Trevor | Administrateur | 26-28 Ludgate Hill B3 1DX Birmingham Victory House | United Kingdom | British | 115467570001 | |||||
| PETTIT, Andrew John | Administrateur | Wigmore Street W1U 1QY London 105 England | England | British | 62947400004 | |||||
| BROWN, John Kenneth | Secrétaire | 40 Beech Avenue G77 5PP Glasgow Renfrewshire | British | 462890002 | ||||||
| MCCALL, Peter Michael | Secrétaire | 19 Bonaly Terrace EH13 0EL Edinburgh Midlothian | British | 119269620001 | ||||||
| BRIAN REID LTD. | Secrétaire désigné | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh | 900018660001 | |||||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Administrateur | Spruce Tree House By Gleneagles PH4 1RG Auchterarder Perthshire | British | 122926460001 | ||||||
| BROOK, Robert William Middleton | Administrateur | Ashchurch Park Villas W12 9SP London 9 | United Kingdom | British | 59050120004 | |||||
| BROWN, John Kenneth | Administrateur | 40 Beech Avenue G77 5PP Glasgow Renfrewshire | Scotland | British | 462890002 | |||||
| CAIRNS, James Scott | Administrateur | 58 Davies Street London W1K 5JF | United Kingdom | British | 33041530004 | |||||
| KENNEDY, John Anthony Bingham | Administrateur | Newhall Carlops EH26 9LY Penicuik Midlothian | Scotland | British | 71043680001 | |||||
| ROBSON, Ronald Alexander | Administrateur | 19 Glasclune Gardens EH39 4RB North Berwick East Lothian | Scotland | British | 104673590001 | |||||
| WHITE, Andrew Edward | Administrateur | Craigend 2 Cromwell Road EH39 4LZ North Berwick East Lothian | Scotland | British | 110163980001 | |||||
| STEPHEN MABBOTT LTD. | Administrateur désigné | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | 900018650001 |
BALDERTON BANBURY LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Account pledge agreement | Créé le 06 févr. 2013 Livré le 08 févr. 2013 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors or any of them to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of its present future conditional and unconditional claims rights title and interest arising from or in relation to all of its bank accounts including any sub-account renewal resignation or replacement. Farnborough support account hsh nordbank ag 1200017427, rent account hsh nordbank ag 1200015521, sale proceeds account hsh nordbank ag 1200015537. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Account assignment | Créé le 26 juil. 2010 Livré le 30 juil. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from teach obligor and he company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions With full title guarantee assigned to the agent its present and future rights and interest in the account designated farnborough support account with a/c no. 44523903 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 22 déc. 2005 Livré le 23 déc. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0