BALDERTON BANBURY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBALDERTON BANBURY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05429527
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BALDERTON BANBURY LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe BALDERTON BANBURY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    105 Wigmore Street
    W1U 1QY London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BALDERTON BANBURY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KENMORE BANBURY LIMITED03 nov. 200503 nov. 2005
    SOUTHLEVEL LIMITED19 avr. 200519 avr. 2005

    Quels sont les derniers comptes de BALDERTON BANBURY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BALDERTON BANBURY LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BALDERTON BANBURY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Richard Bruce Mitchell le 31 déc. 2013

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew John Pettit le 01 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 20 Balderton Street London W1K 6TL à 105 Wigmore Street London W1U 1QY le 12 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 avr. 2014

    État du capital au 22 avr. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2012

    6 pagesAA

    legacy

    7 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2009

    13 pagesAA

    legacy

    8 pagesMG01

    Changement d'adresse du siège social de * 58 Davies Street London W1K 5JF* le 28 juil. 2010

    2 pagesAD01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed kenmore banbury LIMITED\certificate issued on 21/07/10
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name21 juil. 2010

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination de William James Killick en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Lee Maytum en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Cairns en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Henry James Angell-James en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de BALDERTON BANBURY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MITCHELL, Richard Bruce
    Wigmore Street
    W1U 1QY London
    105
    England
    Secrétaire
    Wigmore Street
    W1U 1QY London
    105
    England
    British152314650001
    ANGELL-JAMES, Henry James
    26-28 Ludgate Hill
    B3 1DX Birmingham
    Victory House
    Administrateur
    26-28 Ludgate Hill
    B3 1DX Birmingham
    Victory House
    United KingdomBritish152314900001
    KILLICK, William James
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    Administrateur
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    UkBritish152751860001
    MAYTUM, Lee Trevor
    26-28 Ludgate Hill
    B3 1DX Birmingham
    Victory House
    Administrateur
    26-28 Ludgate Hill
    B3 1DX Birmingham
    Victory House
    United KingdomBritish115467570001
    PETTIT, Andrew John
    Wigmore Street
    W1U 1QY London
    105
    England
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QY London
    105
    England
    EnglandBritish62947400004
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secrétaire
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    British119269620001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    Administrateur
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritish59050120004
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Administrateur
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    CAIRNS, James Scott
    58 Davies Street
    London
    W1K 5JF
    Administrateur
    58 Davies Street
    London
    W1K 5JF
    United KingdomBritish33041530004
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    ROBSON, Ronald Alexander
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish104673590001
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish110163980001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Administrateur désigné
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    BALDERTON BANBURY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Account pledge agreement
    Créé le 06 févr. 2013
    Livré le 08 févr. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its present future conditional and unconditional claims rights title and interest arising from or in relation to all of its bank accounts including any sub-account renewal resignation or replacement. Farnborough support account hsh nordbank ag 1200017427, rent account hsh nordbank ag 1200015521, sale proceeds account hsh nordbank ag 1200015537.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag
    Transactions
    • 08 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Account assignment
    Créé le 26 juil. 2010
    Livré le 30 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from teach obligor and he company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    With full title guarantee assigned to the agent its present and future rights and interest in the account designated farnborough support account with a/c no. 44523903 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 30 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2005
    Livré le 23 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank London Branch
    Transactions
    • 23 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0