WIZARD BONDCO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWIZARD BONDCO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05447232
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WIZARD BONDCO LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WIZARD BONDCO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WIZARD BONDCO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WIZARD BONDCO LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WIZARD BONDCO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 janv. 2015

    État du capital au 22 janv. 2015

    • Capital: GBP 50.861001
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Auth capital restriction removed 30/10/2014
    RES13
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Capitalisation authority 30/10/2014
    RES14

    État du capital après une attribution d'actions au 31 oct. 2014

    • Capital: GBP 50.861001
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Auth capital restriction revoked 30/10/2014
    RES13
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Authority to capitalise 30/10/2014
    RES14

    État du capital après une attribution d'actions au 30 oct. 2014

    • Capital: GBP 4,986,100.14
    4 pagesSH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 31 oct. 2014

    • Capital: GBP 50.58
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 30/10/2014
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 30/10/2014
    RES13

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 30 oct. 2014

    • Capital: GBP 49.86
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 30/10/2014
    RES13

    Cessation de la nomination de Andrew Christopher Carr en tant que directeur le 03 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nicholas John Varney en tant que directeur le 03 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Fiona Jane Rose en tant qu'administrateur le 03 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 28 déc. 2013

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 nov. 2013

    État du capital au 25 nov. 2013

    • Capital: GBP 4,986,099.14
    SH01

    Comptes annuels établis au 29 déc. 2012

    12 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Facilires agreement auth approved 24/06/2013
    RES13

    Inscription de la charge 054472320006

    79 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de WIZARD BONDCO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARMSTRONG, Colin North
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Secrétaire
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    British172030620001
    ARMSTRONG, Colin North
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    United Kingdom
    Administrateur
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    United Kingdom
    United KingdomBritish172030620001
    ROSE, Fiona Jane
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    Administrateur
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    EnglandBritish93616410002
    CARR, Andrew Christopher
    Oakapple Cottage Oak Court
    Church Road Shillingstone
    DT11 0TT Blandford Forum
    Dorset
    Secrétaire
    Oakapple Cottage Oak Court
    Church Road Shillingstone
    DT11 0TT Blandford Forum
    Dorset
    British65490970002
    CORBEN, Darcy
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Secrétaire
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    British111442510002
    DAILLY, Andrew
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    Secrétaire
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    British105982060001
    TOOTH, Matthew David
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    Secrétaire
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    British100150000001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARATTA, Joseph Patrick
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    Administrateur
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    UsaAmerican94259330002
    BUCKLAND, James Lindsay Carnac
    Ashurst
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    Administrateur
    Ashurst
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    British104768550001
    CARR, Andrew Christopher
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Administrateur
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    United KingdomBritish65490970003
    DAILLY, Andrew
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    Administrateur
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    British105982060001
    TOOTH, Matthew David
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    Administrateur
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    EnglandBritish100150000001
    VARNEY, Nicholas John
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Administrateur
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    EnglandBritish50480360003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    WIZARD BONDCO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 28 juin 2013
    Livré le 03 juil. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Unicredit Bank Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Senior Creditors (The Security Agent)
    Transactions
    • 03 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A second confirmatory security agreement
    Créé le 24 mai 2011
    Livré le 31 mai 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Unicredit Bank Ag London Branch
    Transactions
    • 31 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    A confirmatory security agreement
    Créé le 05 août 2010
    Livré le 20 août 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Unicredit Bank, Ag London Branch
    Transactions
    • 20 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security agreement
    Créé le 26 juin 2008
    Livré le 11 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any secured italian creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Ag, London Branch (The Security Agent)
    Transactions
    • 11 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A security agreement
    Créé le 21 mai 2007
    Livré le 31 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured row creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag, London Branch (The Security Agent)
    Transactions
    • 31 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    A security agreement
    Créé le 19 août 2005
    Livré le 31 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag London Branch as Security Agent
    Transactions
    • 31 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0