DUDLEY INFRACARE DEVELOPMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DUDLEY INFRACARE DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05450728 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DUDLEY INFRACARE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Challenge House International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Gloucestershire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DUDLEY INFRACARE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DUDLEY INFRACARE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mai 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 mai 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mai 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour DUDLEY INFRACARE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Nomination de Mr Christopher Edwin Walker en tant qu'administrateur le 10 oct. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2024 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr James Michael Weaver en tant qu'administrateur le 04 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Eugene Martin Prinsloo en tant que directeur le 04 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Andrew Philip Holland en tant que secrétaire le 07 oct. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Georgina Claire Brown en tant que secrétaire le 07 oct. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr Gareth Wyn Jones en tant qu'administrateur le 03 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Matthew Graham Hartland en tant que directeur le 30 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2023 | 3 pages | AA | ||
Nomination de Mr Eugene Martin Prinsloo en tant qu'administrateur le 08 déc. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Mark William Grinonneau en tant que directeur le 20 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2022 | 3 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Daniel Marinus Maria Vermeer en tant que directeur le 27 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Darch en tant que directeur le 21 juin 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2021 | 3 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Charlotte Sophie Ellen Douglass en tant qu'administrateur le 29 juil. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mrs Georgina Claire Brown en tant que secrétaire le 21 juil. 2021 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Philip Holland en tant que secrétaire le 21 juil. 2021 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2020 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Pembroke House Banbury Business Park Adderbury Banbury Oxon OX17 3NS England à Challenge House International Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury GL20 8UQ | 1 pages | AD02 | ||
Qui sont les dirigeants de DUDLEY INFRACARE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLAND, Andrew Philip | Secrétaire | International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House Gloucestershire England | 328138730001 | |||||||
| ANDREWS, Paul Simon | Administrateur | More London Riverside SE1 2AQ London 3 More London Riverside England | England | British | 119057120007 | |||||
| DOUGLASS, Charlotte Sophie Ellen | Administrateur | International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House Gloucestershire England | United Kingdom | British | 245967540001 | |||||
| JONES, Gareth Wyn | Administrateur | St. Peters Square WV1 1SH Wolverhampton Civic Centre England | England | British | 327910260001 | |||||
| WALKER, Christopher Edwin | Administrateur | International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House Gloucestershire England | United Kingdom | British | 267835110001 | |||||
| WEAVER, James Michael | Administrateur | Portland Street M1 3LD Manchester 53 England | England | British | 334406660001 | |||||
| BEVAN, Daniel Peter | Secrétaire | International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House Gloucestershire England | 253174120001 | |||||||
| BROWN, Georgina Claire | Secrétaire | International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House Gloucestershire England | 285474330001 | |||||||
| DAVIES, Roger Andrew | Secrétaire | Farncombe WR12 7LJ Broadway Farncombe House Worcestershire United Kingdom | 162572710001 | |||||||
| HOLLAND, Andrew Philip | Secrétaire | International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House Gloucestershire England | 280349830001 | |||||||
| PHILLIPS, Judith Carlyon | Secrétaire | Banbury Business Park Aynho Road Adderbury OX17 3NS Banbury Pembroke House Oxfordshire England | 179422350001 | |||||||
| POLLARD, Carolyn Jane | Secrétaire | International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House Gloucestershire England | 202466410001 | |||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| BARNES, Simon John | Administrateur | Victoria Square B1 1BD Birmingham One England | England | British | 181364860001 | |||||
| CARROLL, Paul Bryan | Administrateur | c/o Assura Group Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brewhouse Cheshire United Kingdom | England | British | 85123780001 | |||||
| DARCH, Richard | Administrateur | Upper Borough Walls BA1 1RG Bath Archus Limited, Northgate House England | England | British | 178693100001 | |||||
| DARCH, Richard | Administrateur | c/o Ashley House Cliveden Office Village, Lancaster Road Cressex Business Park HP12 3YZ High Wycombe 6 Buckinghamshire England | England | British | 178693100001 | |||||
| GAFFNEY, Kevin Joseph Leo | Administrateur | Brierley Hill Health & Social Care Centre DY5 1RU Venture Way 3rd Floor West Wing Brierley Hill, West Midlands | United Kingdom | British | 155605810001 | |||||
| GRINONNEAU, Mark William | Administrateur | London Road SE1 6LH London Skipton House England | United Kingdom | British | 323896400001 | |||||
| GRINONNEAU, Mark William | Administrateur | Cliveden Office Village, Lancaster Road Cressex Business Park HP12 3YZ High Wycombe 6 Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 323896400001 | |||||
| HARTLAND, Matthew Graham | Administrateur | Venture Way DY5 1RU Brierley Hill Brierley Hill Health And Social Centre England | England | British | 190205840002 | |||||
| HARTLAND, Matthew Graham | Administrateur | Floor St Johns House Union Street DY2 8PP Dudley 4th West Midlands United Kingdom | England | British | 136310470001 | |||||
| HARTSHORNE, David John Morice | Administrateur | c/o Ashley House Cliveden Office Village, Lancaster Road Cressex Business Park HP12 3YZ High Wycombe 6 Buckinghamshire England | England | British | 87382740001 | |||||
| HOLMES, Jonathan | Administrateur | c/o C/O Mr R A Davies Farncombe WR12 7LJ Broadway Farncombe House Worcestershire England | England | British | 107261280002 | |||||
| JONES, David Richard | Administrateur | London Bridge SE1 9RA London Two United Kingdom | England | British | 162465130002 | |||||
| MORRIS, William Edward | Administrateur | International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House Gloucestershire England | United Kingdom | British | 289326600001 | |||||
| POKORA, David Bernard | Administrateur | c/o C/O Mr R A Davies Farncombe WR12 7LJ Broadway Farncombe House Worcestershire England | United Kingdom | British | 63190500001 | |||||
| PRINSLOO, Eugene Martin | Administrateur | Portland Street M1 3LD Manchester Suite 12b England | England | British | 128467230001 | |||||
| RAPER, Sarah Anne, Dr | Administrateur | Banbury Business Park Aynho Road Adderbury OX17 3NS Banbury Pembroke House Oxfordshire England | United Kingdom | British | 116853890001 | |||||
| RAWLINGS, Nigel Keith | Administrateur | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House Lancashire United Kingdom | England | British | 7127460001 | |||||
| SHELDRAKE, Peter John | Administrateur | Charterhouse Square EC1M 6EH London Welken House England | England | British | 164986530026 | |||||
| SIEW, Elaine Ee Leng | Administrateur | c/o C/O Mr R A Davies Farncombe WR12 7LJ Broadway Farncombe House Worcestershire England | United Kingdom | British | 108814710001 | |||||
| SUNTER, Timothy John | Administrateur | Banbury Business Park Aynho Road Adderbury OX17 3NS Banbury Pembroke House Oxfordshire England | England | British | 13959070001 | |||||
| TAYLOR, John Ronald | Administrateur | Brierley Hill Health & Social Care Centre DY5 1RU Venture Way 3rd Floor West Wing Brierley Hill, West Midlands | England | English | 86835850001 | |||||
| VERMEER, Daniel Marinus Maria | Administrateur | Charterhouse Square EC1M 6EH London Welken House England | United Kingdom | Dutch | 245906740001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DUDLEY INFRACARE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudley Infracare Developments Holdings Limited | 12 mai 2017 | International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0