LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05452202 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | The Inspire Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate North Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital au 26 nov. 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 054522020009 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 054522020008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 24 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 054522020009, créée le 17 déc. 2020 | 24 pages | MR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gail Susan Hunter en tant que directeur le 30 sept. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Geraldine Josephine Gallagher en tant que directeur le 30 sept. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 mai 2020 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 22 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 054522020006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 054522020007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Inscription de la charge 054522020008, créée le 10 oct. 2018 | 75 pages | MR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 19 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURRELL, James Alexander | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 192486560001 | ||||
TROY, Anthony Gerrard | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | Ceo | 104500230001 | ||||
BENNISON, Matthew Edward | Secrétaire | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | British | 165708440001 | ||||||
CASTRO, Marcos | Secrétaire | 45 Briavels Court Downshill Road KT18 5HP Epsom Surrey | British | 109248350002 | ||||||
CHILDS, Maureen Anne | Secrétaire | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | British | 35994320001 | ||||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Secrétaire | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | Irish | Director | 185108770001 | |||||
GRAHAM, Annabel Susan | Secrétaire | 9 Manor Mount SE23 3PY London | British | 108637650001 | ||||||
SIDOLI, Domenico | Secrétaire | Cloville Hall Ship Road CM2 8XA Chelmsford Essex | Italian | 64784640002 | ||||||
THOMAS, Marina Louise | Secrétaire | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||
AAIM SECRETARIAL SERVICES LTD | Secrétaire | Fifth Floor 55 King Street M2 4LQ Manchester Lancashire | 124056370001 | |||||||
BENNISON, Matthew Edward | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | England | British | Company Director | 108534390002 | ||||
BENNISON, Matthew Edward | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | British | Company Director | 108534390002 | ||||
CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Administrateur | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | Chartered Accountant | 98778780002 | |||||
CHILDS, Maureen Anne | Administrateur | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | England | British | Information Consultant | 35994320001 | ||||
EIGHTEEN, Stephen Brian | Administrateur | Flat 56 Cinnabar Wharf Central 24 Wapping High Street E1W 1NQ London | United Kingdom | British | Banker | 76313640003 | ||||
ELTON, James Robert | Administrateur | 27 Elsie Road SE22 8DX London | United Kingdom | British | Director | 55689440001 | ||||
FARNELL, Adrian Colin | Administrateur | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | Chartered Accountant | 43015720002 | ||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | England | Irish | Finance Director | 185108770001 | ||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Administrateur | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | England | Irish | Director | 185108770001 | ||||
HUNTER, Gail Susan | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Human Resources Director | 156206540001 | ||||
HUNTER, Gail Susan | Administrateur | Principal Hotels 11 Ripon Road HG1 2JA Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 98567690002 | ||||
MOY, Neal St John | Administrateur | 1 Highberry ME19 5QT Leybourne Kent | British | Bank Employee | 98781970001 | |||||
PAYNE, Brian John | Administrateur | 1 High Street Mews Wimbledon Village SW19 7RG London | England | British | Information Consultant | 38688940001 | ||||
ROBSON, Jeremy Godfrey | Administrateur | The Crossways Corseley Road TN3 9RT Groombridge East Sussex | British | Banker | 98782450001 | |||||
TAGLIAFERRI, Mark Lee | Administrateur | Cadogan Gardens SW3 2RF London Flat 2 105 United Kingdom | England | British | Company Director | 106792270001 | ||||
TAGLIAFERRI, Mark Lee | Administrateur | Flat 2 105 Cadogan Gardens SW3 2RF London | England | British | Director | 106792270001 | ||||
TROY, Anthony Gerrard | Administrateur | Fountains Bent Darley Road, Bristwith HG3 2PN Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | Irish | Director | 104500230001 | ||||
WHITTON, Robert David | Administrateur | 6 Gidea Close Gidea Park RM2 5NP Romford Essex | Uk | British | Director | 69537740005 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal Hayley Group Limited | 06 avr. 2016 | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 17 déc. 2020 Livré le 17 déc. 2020 | Totalement satisfaite | ||
Brève description N/A. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 10 oct. 2018 Livré le 11 oct. 2018 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 01 déc. 2015 Livré le 03 déc. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 12 juin 2014 Livré le 18 juin 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
English law deed of accession | Créé le 27 févr. 2013 Livré le 01 mars 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Accession deed | Créé le 22 déc. 2011 Livré le 29 déc. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of accession | Créé le 19 déc. 2006 Livré le 22 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each of the obligors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of accession | Créé le 13 sept. 2006 Livré le 23 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Share charge and floating charge | Créé le 22 juin 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed charge,the investments including all rights of enforcement,floating charge,all the assets,property and undertaking of the chargor both present and future ,including all its goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0