LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED

LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05452202
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VENICE GEORGE HOLDINGS LIMITED04 oct. 200604 oct. 2006
    GEORGE HOTEL HOLDINGS LIMITED13 mai 200513 mai 2005

    Quels sont les derniers comptes de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 26 nov. 2021

    • Capital: GBP 0.10
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premuim account 12/11/2021
    RES13

    Satisfaction de la charge 054522020009 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 054522020008 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    24 pagesAA

    Inscription de la charge 054522020009, créée le 17 déc. 2020

    24 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Gail Susan Hunter en tant que directeur le 30 sept. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Geraldine Josephine Gallagher en tant que directeur le 30 sept. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 13 mai 2020 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 054522020006 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 054522020007 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 054522020008, créée le 10 oct. 2018

    75 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant192486560001
    TROY, Anthony Gerrard
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishCeo104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    British165708440001
    CASTRO, Marcos
    45 Briavels Court
    Downshill Road
    KT18 5HP Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    45 Briavels Court
    Downshill Road
    KT18 5HP Epsom
    Surrey
    British109248350002
    CHILDS, Maureen Anne
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    Secrétaire
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    British35994320001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    IrishDirector185108770001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Secrétaire
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    SIDOLI, Domenico
    Cloville Hall
    Ship Road
    CM2 8XA Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    Cloville Hall
    Ship Road
    CM2 8XA Chelmsford
    Essex
    Italian64784640002
    THOMAS, Marina Louise
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Secrétaire
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    British80901390001
    AAIM SECRETARIAL SERVICES LTD
    Fifth Floor
    55 King Street
    M2 4LQ Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    Fifth Floor
    55 King Street
    M2 4LQ Manchester
    Lancashire
    124056370001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director108534390002
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director108534390002
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Administrateur
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    BritishChartered Accountant98778780002
    CHILDS, Maureen Anne
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    Administrateur
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    EnglandBritishInformation Consultant35994320001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Administrateur
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritishBanker76313640003
    ELTON, James Robert
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    Administrateur
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    United KingdomBritishDirector55689440001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Accountant43015720002
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    EnglandIrishFinance Director185108770001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Administrateur
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    EnglandIrishDirector185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHuman Resources Director156206540001
    HUNTER, Gail Susan
    Principal Hotels
    11 Ripon Road
    HG1 2JA Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Principal Hotels
    11 Ripon Road
    HG1 2JA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector98567690002
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Administrateur
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    BritishBank Employee98781970001
    PAYNE, Brian John
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    Administrateur
    1 High Street Mews
    Wimbledon Village
    SW19 7RG London
    EnglandBritishInformation Consultant38688940001
    ROBSON, Jeremy Godfrey
    The Crossways
    Corseley Road
    TN3 9RT Groombridge
    East Sussex
    Administrateur
    The Crossways
    Corseley Road
    TN3 9RT Groombridge
    East Sussex
    BritishBanker98782450001
    TAGLIAFERRI, Mark Lee
    Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Flat 2 105
    United Kingdom
    Administrateur
    Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Flat 2 105
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director106792270001
    TAGLIAFERRI, Mark Lee
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Administrateur
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    EnglandBritishDirector106792270001
    TROY, Anthony Gerrard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrishDirector104500230001
    WHITTON, Robert David
    6 Gidea Close
    Gidea Park
    RM2 5NP Romford
    Essex
    Administrateur
    6 Gidea Close
    Gidea Park
    RM2 5NP Romford
    Essex
    UkBritishDirector69537740005

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Principal Hayley Group Limited
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    06 avr. 2016
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement04977436
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    LAGONDA GEORGE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2020
    Livré le 17 déc. 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch
    Transactions
    • 17 déc. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 nov. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 oct. 2018
    Livré le 11 oct. 2018
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch
    Transactions
    • 11 oct. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 nov. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 déc. 2015
    Livré le 03 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transactions
    • 03 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2014
    Livré le 18 juin 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transactions
    • 18 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    English law deed of accession
    Créé le 27 févr. 2013
    Livré le 01 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transactions
    • 01 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Accession deed
    Créé le 22 déc. 2011
    Livré le 29 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 22 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 03 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 13 sept. 2006
    Livré le 23 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and Each of the Secured Parties(The Security Agent)
    Transactions
    • 23 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share charge and floating charge
    Créé le 22 juin 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge,the investments including all rights of enforcement,floating charge,all the assets,property and undertaking of the chargor both present and future ,including all its goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0