SC WINSFORD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSC WINSFORD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05463768
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SC WINSFORD LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe SC WINSFORD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o CURRIE YOUNG LTD
    Alexander House Waters Edge Business Park
    Campbell Road
    ST4 4DB Stoke On Trent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SC WINSFORD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour SC WINSFORD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    15 pagesLIQ14

    Changement d'adresse du siège social de C/O the Currie Young Ltd the Old Barn Caverswall Park Caverswall Lane Stoke on Trent Staffordshire ST3 6HP à C/O Currie Young Ltd Alexander House Waters Edge Business Park Campbell Road Stoke on Trent ST4 4DB le 13 janv. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Changement d'adresse du siège social de 17 Alvaston Business Park Middlewich Road Nantwich Cheshire CW5 6PF à C/O the Currie Young Ltd the Old Barn Caverswall Park Caverswall Lane Stoke on Trent Staffordshire ST3 6HP le 12 août 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 21 juil. 2016

    LRESEX

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juin 2016

    État du capital au 16 juin 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2015

    État du capital au 15 juin 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juin 2014

    État du capital au 06 juin 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2013

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mai 2012 au 30 mai 2012

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    État du capital après une attribution d'actions au 01 juin 2010

    • Capital: GBP 2
    2 pagesSH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2009

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2008

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SC WINSFORD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHANTLER, Melanie Suzanne
    Stretton Hall Farm Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Cheshire
    Secrétaire
    Stretton Hall Farm Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Cheshire
    British51710220001
    CHANTLER, Simon
    Stretton Hall Farm
    Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Stretton Hall Farm
    Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector95498410001

    SC WINSFORD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 11 oct. 2007
    Livré le 18 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 11 oct. 2007
    Livré le 18 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at hooton farm hooton south wirral. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 28 avr. 2006
    Livré le 05 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the south east, north west and south west side of road five winsford industrial estate winsford t/n CH119326 and CH214188. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 05 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 28 avr. 2006
    Livré le 05 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 05 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 oct. 2005
    Livré le 20 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SC WINSFORD LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 juil. 2016Commencement of winding up
    12 déc. 2017Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven John Currie
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    practitioner
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Robert Michael Young
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    practitioner
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0