BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBARRACUDA PROPCO 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05475205
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED ?

    • Débits de boissons et bars (56302) / Hébergement et restauration

    Où se situe BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    3440TH SINGLE MEMBER SHELF TRADING COMPANY LIMITED08 juin 200508 juin 2005

    Quels sont les derniers comptes de BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 juin 2016

    21 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 400 Capability Green Luton Bedfordshire LU1 3AE à 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD le 22 juin 2016

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de David Keith Langer en tant que directeur le 17 juin 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2014

    19 pagesAA

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 08 juin 2015

    LRESEX

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 nov. 2014

    État du capital au 11 nov. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2013

    20 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 nov. 2013

    État du capital au 12 nov. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    23 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes annuels établis au 01 oct. 2011

    22 pagesAA

    Nomination de Tmf Corporate Administration Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * 10 Norwich Street London EC4A 1BD United Kingdom* le 25 oct. 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Lunar House Fieldhouse Lane Globe Park Marlow Bucks SL7 1LW* le 10 oct. 2012

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Christian Keen en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr David Langer en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    England
    Secrétaire
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06902863
    140723560001
    KEEN, Christian
    Lunar House
    Fieldhouse Lane Globe Park
    SL7 1LW Marlow
    Bucks
    Secrétaire
    Lunar House
    Fieldhouse Lane Globe Park
    SL7 1LW Marlow
    Bucks
    169284670001
    MORGAN, Nicholas Mark
    55 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrard's Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    55 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrard's Cross
    Buckinghamshire
    British106335450001
    VARDIGANS, Simon Geoffrey
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    United Kingdom
    Secrétaire
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    United Kingdom
    British44988510001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secrétaire désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024810001
    BISS, Teresa Jane
    Inglenook
    Vicarage Lane Laleham
    TW18 1UE Staines
    Middlesex
    Administrateur
    Inglenook
    Vicarage Lane Laleham
    TW18 1UE Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish106335460001
    JONES, Graham Colin
    Clive Lodge
    Wellington Square
    GL50 4JU Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Clive Lodge
    Wellington Square
    GL50 4JU Cheltenham
    Gloucestershire
    British95950700001
    LANGER, David Keith
    Eton Avenue
    NW3 3ET London
    61
    United Kingdom
    Administrateur
    Eton Avenue
    NW3 3ET London
    61
    United Kingdom
    EnglandCanadian134088480001
    MCQUATER, Mark Robert
    Lashbrook Lodge
    New Road Shiplake
    RG9 3LH Henley
    Oxfordshire
    Administrateur
    Lashbrook Lodge
    New Road Shiplake
    RG9 3LH Henley
    Oxfordshire
    United KingdomBritish72099650001
    MORGAN, Nicholas Mark
    55 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrard's Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    55 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrard's Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish106335450001
    PRICE, Stephen Vincent
    Southview
    1 Earnshaw Barns Middlewich Road
    CW10 9NE Byley
    Cheshire
    Administrateur
    Southview
    1 Earnshaw Barns Middlewich Road
    CW10 9NE Byley
    Cheshire
    EnglandBritish103543030001
    STRINGER, Richard Peter
    Agraria Road
    GU2 4LG Guildford
    68
    Surrey
    Administrateur
    Agraria Road
    GU2 4LG Guildford
    68
    Surrey
    EnglandBritish150670420001
    VARDIGANS, Simon Geoffrey
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    United Kingdom
    Administrateur
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    United Kingdom
    EnglandBritish44988510001
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Administrateur désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024790001
    SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Administrateur désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024800001

    BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 10 juil. 2009
    Livré le 21 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a sandeman bulding 16 kinnoull street perth t/no. PTH7123 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 21 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security
    Créé le 10 juil. 2009
    Livré le 21 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a 60, 62 and 64 high street kirkcaldy t/no.FFE42379 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 21 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security
    Créé le 10 juil. 2009
    Livré le 21 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a cambio 1 corn exchange road 61 king street stirling, t/no.STG29157 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 21 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 10 juil. 2009
    Livré le 15 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee or any delegate of the security trustee or the finance parties (or any of them) (other than newco) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Secured Parties) (the "Security Trustee")
    Transactions
    • 15 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2009
    • 06 mars 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 12 juin 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Supplemental legal charge
    Créé le 25 janv. 2007
    Livré le 01 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any delegate and the opco finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The additional property being 146-148 high street, bangor, gwynedd t/no's WA734784, WA508890, WA964349 and CYM251864, and all buildings and fixtures and fixed plant and/or machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof, all proceeds of sale and the benefit of all covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal charge
    Créé le 25 janv. 2007
    Livré le 01 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any delegate and the opco finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The additional property being 22 market place, long eaton, nottinghamshire t/no DY271339, and all buildings and fixtures and fixed plant and/or machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof, all proceeds of sale and the benefit of all covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal charge
    Créé le 25 janv. 2007
    Livré le 01 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any delegate and the opco finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The additional property being 16 high street, yeadon, west yorkshire t/no's WYK102346 (f/h) and wyk 102348 (l/h), and all buildings and fixtures and fixed plant and/or machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof, all proceeds of sale and the benefit of all covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal charge
    Créé le 25 janv. 2007
    Livré le 01 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any delegate and the opco finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The additional property being 30-32 old church road, chingford t/no EGL92917, and all buildings and fixtures and fixed plant and/or machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof, all proceeds of sale and the benefit of all covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal charge
    Créé le 25 janv. 2007
    Livré le 01 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any delegate and the opco finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The additional property being old mail house, 3 south street, ilkeston, derbyshire t/no DY368142, and all buildings and fixtures and fixed plant and/or machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof, all proceeds of sale and the benefit of all covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 24 january 2006 and
    Créé le 14 déc. 2005
    Livré le 26 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    60-64 high street kirkcaldy t/n FFE4237.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 26 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal charge
    Créé le 14 déc. 2005
    Livré le 23 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and to the senior finance parties (or any of them) and the mezzanine finance parties (or any of them) and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a 101 front street, whickham, newcastle t/no (f/h) TY352756 and the f/h property k/a 2-6 percy street, hanley, stoke on trent t/no SF381077 and the l/h property k/a 13 london road, sheffield t/no SYK158081 for further property charged please refer to the form 395 all buildings and fixtures (including trade fixtures and fittings) and fixed plant /or machinery, all proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The Securitytrustee)
    Transactions
    • 23 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 11 august 2005 and
    Créé le 29 juil. 2005
    Livré le 01 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects known as sandeman building 16 kinnoull street perth t/n PTH7123.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 01 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 11 august 2005 and
    Créé le 29 juil. 2005
    Livré le 01 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects known as cambio 1 corn exchange road/61 king street stirling t/n STG29157.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 01 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 11 august 2005 and
    Créé le 29 juil. 2005
    Livré le 31 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee the senior finance parties (or any of them) the mezzanine finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a sandeman building 16 kinnoull street perth t/NPTH7123. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trstee for the Secured Parties) (the Securitytrustee)
    Transactions
    • 31 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 11 august 2005 and
    Créé le 29 juil. 2005
    Livré le 31 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee the senior finance parties (or any of them) the mezzanine finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a cambio 1 corn exchange road 61 king street stirling t/n STG29157. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trstee for the Secured Parties) (the Securitytrustee)
    Transactions
    • 31 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 juil. 2005
    Livré le 11 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior finance parties or any of them, and the mezzanine finance parties or any of them and any delegate and the opco finance parties or any of them and any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 140A church street, preston t/nos LA787576 and LA749827 and the f/h property k/a 1 market place, mansfield, t/no NT271757, the f/h property k/a 65 fore bond gate, bishop auckland, t/no DU200261 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties and Opco Finance Party(Security Trustee)
    Transactions
    • 11 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 12 juin 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)

    BARRACUDA PROPCO 2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 juin 2015Commencement of winding up
    30 nov. 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Kirkhope
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    practitioner
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Chad Griffin
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    practitioner
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0