DERWENTSIDE HOMES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DERWENTSIDE HOMES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Converti / Fermé |
| Forme juridique | Converti ou fermé |
| Numéro de société | 05484129 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DERWENTSIDE HOMES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Greengates House Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley County Durham United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DERWENTSIDE HOMES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour DERWENTSIDE HOMES LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour DERWENTSIDE HOMES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificat d'immatriculation d'une société de secours mutuel | 4 pages | CERTIPS | ||||||||||
Divers Forms b & z convert to i&ps | 2 pages | MISC | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Derek Robson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Watts Stelling en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Davies en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Alderson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2013 | 61 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 juin 2013 sans liste des membres | 9 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Clive Robson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jill Te Aho en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Janice Docherty en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Inscription de la charge 054841290004 | 8 pages | MR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Sebert Leslie Cox Obe en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Phillip Toal en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ann Manley en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven Errington en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 30 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2012 | 55 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 juin 2012 sans liste des membres | 16 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Derek William Robson le 13 juin 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Davies le 13 juin 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Errington le 13 juin 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2011 | 53 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 juin 2011 sans liste des membres | 14 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DERWENTSIDE HOMES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLINTIRE, Keith Anthony | Secrétaire | Denehurst Hawthorn SR7 8SH Seaham | British | 113760890001 | ||||||
| ARMSTRONG, Joseph | Administrateur | 44 Commercial Street Cornsay Colliery DH7 9BW Durham | United Kingdom | British | 85611670001 | |||||
| BLACKBURN, Christine Mary | Administrateur | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham United Kingdom | England | British | 162303980001 | |||||
| COX OBE, Sebert Leslie | Administrateur | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham United Kingdom | England | British | 175890300001 | |||||
| HUMPHREY, Richard | Administrateur | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham United Kingdom | England | English | 162303300001 | |||||
| PARKES, Kevin John | Administrateur | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham United Kingdom | United Kingdom | British | 162303370001 | |||||
| ROBSON, Derek William | Secrétaire | 16 Burns Close DH9 6TP Stanley County Durham | British | 68718250002 | ||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| ALDERSON, Robert | Administrateur | Birch Crescent Burnopfield NE16 6JJ Newcastle Upon Tyne 100 Tyne And Wear England | England | British | 132515220001 | |||||
| BENSON, Glynis | Administrateur | 47 Dunelm Road Moorside DH8 8HP Consett County Durham | England | British | 92964000001 | |||||
| CHRISTER, Carl | Administrateur | Queens Parade DH9 8YJ Annfield Plain 2 Co Durham | England | British | 139283660001 | |||||
| CLARK, Brenda | Administrateur | 71 Denecrest Medomsley DH8 6PY Consett County Durham | British | 116791700001 | ||||||
| DAVIES, Mark | Administrateur | Ridgewood Villas NE3 1SH Newcastle Upon Tyne 2 United Kingdom | England | British | 116791740002 | |||||
| DOCHERTY, Janice | Administrateur | 10 Surtees Terrace Craghead DH9 6EA Stanley County Durham | England | British | 102477060001 | |||||
| ERRINGTON, Steven | Administrateur | Willow Way Ponteland NE20 9RF Newcastle Upon Tyne 40 England | United Kingdom | British | 135160540002 | |||||
| LLEWELLYN, David | Administrateur | 7 George Street Blackhill DH8 0AE Consett Durham | British | 91264990001 | ||||||
| MANLEY, Ann | Administrateur | 37 Birch Crescent Burnopfield NE16 6JQ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | 116791780001 | |||||
| MILBURN, Olga | Administrateur | 4 Clarence Terrace Tantobie DH9 9TF Stanley County Durham | British | 116791790001 | ||||||
| PARKER, Ann | Administrateur | 7 Dene View East Stanley DH9 6RB Stanley County Durham | England | British | 116791800001 | |||||
| PROUD, William | Administrateur | 15 The Ridings Catchgate DH9 8EE Stanley County Durham | British | 116791830001 | ||||||
| RAFFERTY, James | Administrateur | 25 Greenwell Park DH7 0NW Lanchester County Durham | British | 116791840001 | ||||||
| REDPATH, Amy | Administrateur | Biddlestone Road Heaton NE6 5SL Newcastle Upon Tyne 63 Tyne & Wear England | England | British | 116791860002 | |||||
| ROBSON, Clive, County Councillor | Administrateur | Constance Street DH8 5DY Consett 23 Durham | England | British | 132314740001 | |||||
| ROBSON, Derek William | Administrateur | Magdalene Court Medomsley DH8 6RF Consett 16 County Durham United Kingdom | England | British | 68718250003 | |||||
| STELLING, Watts, Councillor | Administrateur | 53 Bradley Cottages Leadgate DH8 6JY Consett County Durham | England | British | 112350240001 | |||||
| STOKER, Karen Jane | Administrateur | 10 Fenwick Way DH8 5FD Consett County Durham | England | British | 116791890001 | |||||
| TAYLOR, Denise | Administrateur | 76 North Magdalene Medomsley DH8 6RQ Consett County Durham | England | British | 116791900001 | |||||
| TE AHO, Jill | Administrateur | Acton Dene East Stanley NE16 6JJ Stanley 14 County Durham | England | British | 132754060001 | |||||
| TOAL, Phillip | Administrateur | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham United Kingdom | England | British | 162302270001 | |||||
| WILLIAMSON, Jane | Administrateur | 6 Derby Crescent Moorside DH8 8DZ Consett County Durham | British | 116791910001 | ||||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Administrateur | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76332110001 |
DERWENTSIDE HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 24 avr. 2013 Livré le 02 mai 2013 | En cours | ||
Brève description Lynwood house durham road lanchester county durham. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Account charge | Créé le 04 déc. 2006 Livré le 15 déc. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all moneys (including interest) from time to time standing to the credit of the proceeds account and the sinking fund and the debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 04 déc. 2006 Livré le 15 déc. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first floating charge the whole of the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed charge | Créé le 04 déc. 2006 Livré le 15 déc. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0