MPL DACS 1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMPL DACS 1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05484226
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MPL DACS 1 LIMITED ?

    • Activités des sociétés de financement hypothécaire (64922) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe MPL DACS 1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MPL DACS 1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour MPL DACS 1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Cessation de la nomination de David Gareth Thompson en tant que directeur le 19 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 juin 2019

    8 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 juin 2018

    8 pagesLIQ03

    Nomination de Mr Craig James Mckinlay en tant qu'administrateur le 01 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Craig James Mckinlay en tant qu'administrateur le 01 avr. 2018

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    15 juin 2018Part Rectified The service address of the director was removed from the AP01 on 15/06/2018 as it was invalid or ineffective.

    Cessation de la nomination de Keith Leslie Street en tant que directeur le 31 janv. 2018

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 30 Finsbury Square London EC2P 2YU à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham Berkshire RG41 5TS le 11 juil. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 juin 2017

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 03 mai 2017

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal pour annuler la liquidation

    1 pagesOCRESCIND

    Changement d'adresse du siège social de Ascot House Maidenhead Office Park Maidenhead SL6 3QQ à No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 11 juil. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 juin 2016

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de Reading International Business Park Basingstoke Road Reading Berkshire RG2 6DB à Ascot House Maidenhead Office Park Maidenhead SL6 3QQ le 11 janv. 2016

    2 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Gareth Thompson le 20 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2015 au 30 sept. 2015

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr David Gareth Thompson en tant qu'administrateur le 20 nov. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Esther Elaine Morley en tant que directeur le 05 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Harvey Morris en tant que secrétaire le 13 oct. 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Ian Arthur Henderson en tant que directeur le 30 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de MPL DACS 1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCKINLAY, Craig James
    Maidenhead Office Park
    SL6 3QQ Maidenhead
    Ascot House
    Administrateur
    Maidenhead Office Park
    SL6 3QQ Maidenhead
    Ascot House
    United KingdomBritishSales & Marketing Director199893360001
    MORRIS, James Harvey
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    194731850001
    MURRAY, Dominic
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    Secrétaire
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    Other121945810002
    PINDORIA, Shilla
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    157089780001
    TOMSETT, Ann Sara
    7 Oak Lodge
    Chantry Square
    W8 5UL London
    Secrétaire
    7 Oak Lodge
    Chantry Square
    W8 5UL London
    British58027970002
    KENSINGTON SECRETARIES LIMITED
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    Secrétaire
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    109008650002
    BLUNDELL, Roger Frederick Crawford
    Vineyard Hill Road
    SW19 7JL London
    61
    Administrateur
    Vineyard Hill Road
    SW19 7JL London
    61
    EnglandBritishGroup Finance Director56525730002
    CLAYS, Malcolm
    9 Llewelyn Park
    RG10 9NG Twyford
    Berkshire
    Administrateur
    9 Llewelyn Park
    RG10 9NG Twyford
    Berkshire
    BritishDirector Of Finance124718190001
    COLSELL, Steven James
    Limes House
    Bytham Road Ogbourne St George
    SN8 1TD Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Limes House
    Bytham Road Ogbourne St George
    SN8 1TD Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishFinance Director101387770001
    GOWER, Adrian Walton
    3 Windmill Road
    TW8 0QD Brentford
    Middlesex
    Administrateur
    3 Windmill Road
    TW8 0QD Brentford
    Middlesex
    BritishCorporate Services Director101422170001
    HENDERSON, Ian Arthur
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishChief Executive207828370001
    HUTCHINSON, Alison
    1 Sheldon Square
    W2 6PU London
    Administrateur
    1 Sheldon Square
    W2 6PU London
    BritishManaging Director74158760003
    LLOYD, Derek
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    Administrateur
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    United KingdomBritishHead Of Treasury124660210001
    LLOYD, Derek
    3 Bovingdon Heights
    SL7 2JR Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    3 Bovingdon Heights
    SL7 2JR Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishHead Of Treasury124660210001
    MALTBY, John Neil
    Priory House
    Priory Close
    BR7 5LB Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Priory House
    Priory Close
    BR7 5LB Chislehurst
    Kent
    EnglandBritishChief Executive84264890001
    MCKENNA, Kevin Patrick
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    EnglandIrishChief Operating Officer Investec Capital Markets169418850001
    MORLEY, Esther Elaine
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director150084860001
    PATEL, Anant
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    Administrateur
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    EnglandBritishInvestment Banker129677000001
    RALPH, Nicholas James
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    Administrateur
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    United KingdomBritishFinance130070970001
    SALTER, Andrew Kershaw
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    Administrateur
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    United KingdomBritishFinance77737200002
    STREET, Keith Leslie
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    United KingdomBritishHead Of Kensington Mortgages165122930001
    THOMPSON, David Gareth
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant203018830001
    TOMSETT, Ann Sara
    3a Palace Green
    W8 4TR London
    Administrateur
    3a Palace Green
    W8 4TR London
    EnglandBritishChief Solicitor58027970005
    CAPITA TRUST CORPORATE LIMITED
    Phoenix House
    18 King William Street
    EC4N 7HE London
    Administrateur
    Phoenix House
    18 King William Street
    EC4N 7HE London
    109010570001
    CAPITA TRUST CORPORATE SERVICES LIMITED
    The Registry
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    Kent
    Administrateur
    The Registry
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    Kent
    114688040003

    MPL DACS 1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2007
    Livré le 28 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from a chargor or the borrower to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and to the charged securities all sums and in and to the secured loan account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 28 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge
    Créé le 08 août 2005
    Livré le 12 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title and interest in the charged securities, the residual revenue, and the mpl dacs 1 limited secured loan account with barclays bank PLC account no 30552216 sort code 20-19-90,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    MPL DACS 1 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 juin 2016Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    2
    DateType
    14 juin 2017Commencement of winding up
    22 août 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0