THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL

THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 05498489
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?

    Adresse du siège social
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Jeffrey Richard De Corban Evans en tant que directeur le 30 juin 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Simon Edward Arnell en tant que directeur le 30 juin 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Simon Edward Arnell en tant que directeur le 30 juin 2018

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2017

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alan Colin Drake Yarrow en tant que directeur le 31 août 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Clare Viven Tattersall en tant que directeur le 31 août 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Henry George Pollard en tant que directeur le 31 août 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Catherine Sidony Mcguinness en tant que directeur le 31 août 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Michael Henry Hiard en tant que directeur le 16 mars 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2016

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2015 sans liste des membres

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan Colin Drake Yarrow le 04 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dominic Lawrence Charleworth Fry le 04 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Clare Viven Tattersall le 04 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Catherine Sidony Mcguinness le 04 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2014 sans liste des membres

    10 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANDREWS, Gregory Edward
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    176868320001
    DE WALDEN, Jan
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish185605820001
    FRY, Dominic Lawrence Charlesworth
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish128983220001
    MAINELLI, Michael Raymond
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    United KingdomIrish152492730001
    MUIR, Robert Wallace
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish142389130001
    PATMAN, Delva
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish158160480001
    PERRICONE, Guido Robert
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    EnglandItalian American English176868830001
    GORDON, Andrew Edward
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    168175810001
    HEATHCOTE, Robert
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    163473920001
    HOGARTH SMITH, Anthony Clive
    The Lodge
    Wiggonholt
    RH20 2EL Pulborough
    West Sussex
    Secrétaire
    The Lodge
    Wiggonholt
    RH20 2EL Pulborough
    West Sussex
    British121121430001
    SIMPKIN, Michael Lloyd
    Scrace House
    Copperfield Manor, Manor Lane
    RH13 6PL Coolhurst Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    Scrace House
    Copperfield Manor, Manor Lane
    RH13 6PL Coolhurst Horsham
    West Sussex
    British72211230004
    ARNELL, James Simon Edward
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish84362710004
    ARNOLD, David James
    37 Springfield Park
    North Parade
    RH12 2BF Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    37 Springfield Park
    North Parade
    RH12 2BF Horsham
    West Sussex
    British80640520001
    BINNINGTON, Timothy John
    Thakeham Place
    Thakeham
    RH20 3EP Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    Thakeham Place
    Thakeham
    RH20 3EP Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritish4831260001
    BLOOMFIELD, Peter
    Boxgrove
    Byworth
    GU28 0HN Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Boxgrove
    Byworth
    GU28 0HN Petworth
    West Sussex
    British83245410001
    BROUGHAM, John Michael
    Greenrufe Penn Lane
    Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Greenrufe Penn Lane
    Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish16686260001
    CARDEN, Anthony Richard Paul
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish160029400001
    EVANS, Jeffrey Richard De Corban, Alderman The Lord Mountevans
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish95021530001
    FARNFIELD, Peter John
    7 Howard Road
    RH4 3HR Dorking
    Surrey
    Administrateur
    7 Howard Road
    RH4 3HR Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish107658310001
    FARRINGTON, David
    Chorley Farm House
    Bottom Road, West Wycombe
    HP14 4BS High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Chorley Farm House
    Bottom Road, West Wycombe
    HP14 4BS High Wycombe
    Buckinghamshire
    British106156710001
    GARBUTT, John
    Flat 4 5 Sloane Gardens
    SW1W 8EA London
    Administrateur
    Flat 4 5 Sloane Gardens
    SW1W 8EA London
    EnglandBritish31734100002
    GILBERTSON, Moyna Patricia
    10 Bluecoat Pond
    Christs Hospital
    RH13 0NW Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    10 Bluecoat Pond
    Christs Hospital
    RH13 0NW Horsham
    West Sussex
    British107657910001
    HIARD, Michael Henry
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish168610320001
    HOFFMAN, Thomas Dieter Dirk
    Old Curteis
    Biddenden
    TN27 8JN Kent
    Administrateur
    Old Curteis
    Biddenden
    TN27 8JN Kent
    United KingdomBritish73902410001
    HUGHESDON, John Stephen
    44 Christchurch Road
    DA15 7HQ Sidcup
    Kent
    Administrateur
    44 Christchurch Road
    DA15 7HQ Sidcup
    Kent
    British18422000001
    JOHNSON KCB OBE MC, Garry Dene, Sir
    Mantua House
    St James Lane
    SO22 4NX Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Mantua House
    St James Lane
    SO22 4NX Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish52467830003
    LANYON, Lance Edward, Professor
    9 School Lane
    Bricket Wood
    AL2 3XS St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 School Lane
    Bricket Wood
    AL2 3XS St. Albans
    Hertfordshire
    British70665880001
    LEWIS, David Thomas Rowell
    Whitewalls
    Red Copse Lane, Boars Hill
    OX1 5ER Oxford
    Administrateur
    Whitewalls
    Red Copse Lane, Boars Hill
    OX1 5ER Oxford
    British16639340002
    LEWIS, David Thomas Rowell
    Whitewalls
    Red Copse Lane, Boars Hill
    OX1 5ER Oxford
    Administrateur
    Whitewalls
    Red Copse Lane, Boars Hill
    OX1 5ER Oxford
    British16639340002
    LINTOTT, Susan Elizabeth, Dr
    49 St Barnabas Road
    CB1 2BX Cambridge
    Administrateur
    49 St Barnabas Road
    CB1 2BX Cambridge
    United KingdomBritish63315120001
    LUGTON, Keth Stephen Haddington
    49 Harefield Avenue
    SM2 7ND Sutton
    Surrey
    Administrateur
    49 Harefield Avenue
    SM2 7ND Sutton
    Surrey
    British127795750001
    MCGUINNESS, Catherine Sidony
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    The Counting House
    Christs Hospital
    RH13 0YP Horsham
    West Sussex
    EnglandEnglish,Irish45605990001
    MURRAY, Simon Anthony
    150 Langton Way
    Blackheath
    SE3 7JS London
    Administrateur
    150 Langton Way
    Blackheath
    SE3 7JS London
    EnglandBritish79856110001
    PARMLEY, Wendy Davina Calder
    125 Marsham Court
    Marsham Street
    SW1P 4LB London
    Administrateur
    125 Marsham Court
    Marsham Street
    SW1P 4LB London
    United KingdomBritish34930500001
    PAYNE, Donald Hedley
    Latchmoor
    Westerham Road
    RH8 0SW Oxted
    Surrey
    Administrateur
    Latchmoor
    Westerham Road
    RH8 0SW Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish106156700001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    04 juil. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 avr. 2014
    Livré le 23 avr. 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 23 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Legal charge
    Créé le 18 mars 2013
    Livré le 21 mars 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a being 49-51 bedford square london t/n NGL875403.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 26 juin 2012
    Livré le 28 juin 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being 93 and 95 high street guildford surrey t/no SY467146.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 11 avr. 2011
    Livré le 19 avr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company as trustee of christ's hospital foundation to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H 21 church street kingston upon thames surrey t/no SY141821 and 23/25 and 27 church street kingston upon thames surrey t/no SGL688945.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0