THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 05498489 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?
| Adresse du siège social | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Jeffrey Richard De Corban Evans en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de James Simon Edward Arnell en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de James Simon Edward Arnell en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2017 | 3 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Alan Colin Drake Yarrow en tant que directeur le 31 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Clare Viven Tattersall en tant que directeur le 31 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de James Henry George Pollard en tant que directeur le 31 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Catherine Sidony Mcguinness en tant que directeur le 31 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Michael Henry Hiard en tant que directeur le 16 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2016 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2016 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2015 | 3 pages | AA | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2015 sans liste des membres | 8 pages | AR01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Alan Colin Drake Yarrow le 04 juil. 2015 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Dominic Lawrence Charleworth Fry le 04 juil. 2015 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Clare Viven Tattersall le 04 juil. 2015 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Catherine Sidony Mcguinness le 04 juil. 2015 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2014 | 3 pages | AA | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2014 sans liste des membres | 10 pages | AR01 | ||
Qui sont les dirigeants de THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREWS, Gregory Edward | Secrétaire | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | 176868320001 | |||||||
| DE WALDEN, Jan | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | England | British | 185605820001 | |||||
| FRY, Dominic Lawrence Charlesworth | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 128983220001 | |||||
| MAINELLI, Michael Raymond | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | United Kingdom | Irish | 152492730001 | |||||
| MUIR, Robert Wallace | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | England | British | 142389130001 | |||||
| PATMAN, Delva | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 158160480001 | |||||
| PERRICONE, Guido Robert | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | England | Italian American English | 176868830001 | |||||
| GORDON, Andrew Edward | Secrétaire | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | 168175810001 | |||||||
| HEATHCOTE, Robert | Secrétaire | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | 163473920001 | |||||||
| HOGARTH SMITH, Anthony Clive | Secrétaire | The Lodge Wiggonholt RH20 2EL Pulborough West Sussex | British | 121121430001 | ||||||
| SIMPKIN, Michael Lloyd | Secrétaire | Scrace House Copperfield Manor, Manor Lane RH13 6PL Coolhurst Horsham West Sussex | British | 72211230004 | ||||||
| ARNELL, James Simon Edward | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | England | British | 84362710004 | |||||
| ARNOLD, David James | Administrateur | 37 Springfield Park North Parade RH12 2BF Horsham West Sussex | British | 80640520001 | ||||||
| BINNINGTON, Timothy John | Administrateur | Thakeham Place Thakeham RH20 3EP Pulborough West Sussex | England | British | 4831260001 | |||||
| BLOOMFIELD, Peter | Administrateur | Boxgrove Byworth GU28 0HN Petworth West Sussex | British | 83245410001 | ||||||
| BROUGHAM, John Michael | Administrateur | Greenrufe Penn Lane Tanworth In Arden B94 5HH Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 16686260001 | |||||
| CARDEN, Anthony Richard Paul | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | England | British | 160029400001 | |||||
| EVANS, Jeffrey Richard De Corban, Alderman The Lord Mountevans | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 95021530001 | |||||
| FARNFIELD, Peter John | Administrateur | 7 Howard Road RH4 3HR Dorking Surrey | United Kingdom | British | 107658310001 | |||||
| FARRINGTON, David | Administrateur | Chorley Farm House Bottom Road, West Wycombe HP14 4BS High Wycombe Buckinghamshire | British | 106156710001 | ||||||
| GARBUTT, John | Administrateur | Flat 4 5 Sloane Gardens SW1W 8EA London | England | British | 31734100002 | |||||
| GILBERTSON, Moyna Patricia | Administrateur | 10 Bluecoat Pond Christs Hospital RH13 0NW Horsham West Sussex | British | 107657910001 | ||||||
| HIARD, Michael Henry | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 168610320001 | |||||
| HOFFMAN, Thomas Dieter Dirk | Administrateur | Old Curteis Biddenden TN27 8JN Kent | United Kingdom | British | 73902410001 | |||||
| HUGHESDON, John Stephen | Administrateur | 44 Christchurch Road DA15 7HQ Sidcup Kent | British | 18422000001 | ||||||
| JOHNSON KCB OBE MC, Garry Dene, Sir | Administrateur | Mantua House St James Lane SO22 4NX Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 52467830003 | |||||
| LANYON, Lance Edward, Professor | Administrateur | 9 School Lane Bricket Wood AL2 3XS St. Albans Hertfordshire | British | 70665880001 | ||||||
| LEWIS, David Thomas Rowell | Administrateur | Whitewalls Red Copse Lane, Boars Hill OX1 5ER Oxford | British | 16639340002 | ||||||
| LEWIS, David Thomas Rowell | Administrateur | Whitewalls Red Copse Lane, Boars Hill OX1 5ER Oxford | British | 16639340002 | ||||||
| LINTOTT, Susan Elizabeth, Dr | Administrateur | 49 St Barnabas Road CB1 2BX Cambridge | United Kingdom | British | 63315120001 | |||||
| LUGTON, Keth Stephen Haddington | Administrateur | 49 Harefield Avenue SM2 7ND Sutton Surrey | British | 127795750001 | ||||||
| MCGUINNESS, Catherine Sidony | Administrateur | The Counting House Christs Hospital RH13 0YP Horsham West Sussex | England | English,Irish | 45605990001 | |||||
| MURRAY, Simon Anthony | Administrateur | 150 Langton Way Blackheath SE3 7JS London | England | British | 79856110001 | |||||
| PARMLEY, Wendy Davina Calder | Administrateur | 125 Marsham Court Marsham Street SW1P 4LB London | United Kingdom | British | 34930500001 | |||||
| PAYNE, Donald Hedley | Administrateur | Latchmoor Westerham Road RH8 0SW Oxted Surrey | United Kingdom | British | 106156700001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 04 juil. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
THE COUNCIL OF ALMONERS OF CHRIST'S HOSPITAL a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 14 avr. 2014 Livré le 23 avr. 2014 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 18 mars 2013 Livré le 21 mars 2013 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/a being 49-51 bedford square london t/n NGL875403. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 26 juin 2012 Livré le 28 juin 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/H property k/a or being 93 and 95 high street guildford surrey t/no SY467146. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 11 avr. 2011 Livré le 19 avr. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company as trustee of christ's hospital foundation to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/H 21 church street kingston upon thames surrey t/no SY141821 and 23/25 and 27 church street kingston upon thames surrey t/no SGL688945. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0