CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED

CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05500819
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Pinsent Masons Llp
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13
    A966H1RT

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 janv. 2020

    9 pagesLIQ03
    A91VSF28

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 janv. 2019

    8 pagesLIQ03
    A827520H

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600
    A6ZZPHYW

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 janv. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01
    A6YZWF6O

    Changement d'adresse du siège social de Part Ground Floor & First Floor Two Parklands Great Park Rubery Rednal Birmingham B45 9PZ à C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB le 20 déc. 2017

    1 pagesAD01
    X6LPU115

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X6CATR3E

    Notification de Future Life Realty (North) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC02
    X6CATMA2

    Cessation de la nomination de Patricia Lesley Lee en tant que directeur le 31 juil. 2017

    1 pagesTM01
    X6BTSZVC

    legacy

    1 pagesSH20
    L69MA2LM

    État du capital au 29 juin 2017

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19
    L69MA2LE

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    L69MA2M2

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 28/06/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    7 pagesAA
    A61ROM4O

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X5C8ZWRN

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    8 pagesAA
    A4YI3AKQ

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 sept. 2015

    État du capital au 07 sept. 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01
    X4FFM5QP

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    8 pagesAA
    A3NQXOCW

    Nomination de Ms Patricia Lesley Lee en tant qu'administrateur le 06 oct. 2014

    2 pagesAP01
    X3KWRP88

    Cessation de la nomination de Albert Edward Smith en tant que directeur le 22 oct. 2014

    1 pagesTM01
    X3JM0HVL

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    X3CTU0RF

    Cessation de la nomination de Katharine Amelia Christabel Kandelaki en tant que secrétaire le 06 sept. 2013

    1 pagesTM02
    X3CTU0QZ

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04
    A39S784A

    Qui sont les dirigeants de CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MANSON, David Lindsay
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    Administrateur
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    United KingdomBritishDirector167628190001
    AMLANI, Pritesh
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    BritishDirector125206220002
    KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel
    Two Parklands Great Park
    Rubery Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    Two Parklands Great Park
    Rubery Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    160356550001
    O'FLYNN, Bridget
    79 Chessel Avenue
    Bitterne
    SO19 4DY Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    79 Chessel Avenue
    Bitterne
    SO19 4DY Southampton
    Hampshire
    English183822480001
    AMLANI, Pritesh
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector125206220002
    CAHILL, Norman Anthony
    79 Chessel Avenue
    Bitterne
    SO19 4DY Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    79 Chessel Avenue
    Bitterne
    SO19 4DY Southampton
    Hampshire
    EnglandIrishCompany Director82663960001
    LEE, Patricia Lesley
    Two Parklands Great Park
    Rubery Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    Administrateur
    Two Parklands Great Park
    Rubery Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United KingdomBritishChief Executive192233540001
    PERRY, David William
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    Administrateur
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    EnglandBritishNone33988060002
    SMITH, Albert Edward
    Two Parklands Great Park
    Rubery Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Two Parklands Great Park
    Rubery Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector77631340001
    TREON, Anoup
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    Administrateur
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    United KingdomBritishBusiness Executive152212470001
    TREON, Jaynee Sunita
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    Administrateur
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    United KingdomBritishDirector42532090004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Future Life Realty (North) Ltd
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    06 avr. 2016
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement05604752
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    06 juil. 2016La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 juil. 2012
    Livré le 03 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 03 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 25 mars 2011
    Livré le 06 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them on any account whatsoever and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from each other chargor and each other member of the group to the lenders or any of them on any account whatsoever and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 06 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 mars 2008
    Livré le 02 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 02 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Share charge
    Créé le 31 août 2005
    Livré le 08 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All shares in cornerstone service support limited being 4 ordinary shares at £1 per share and all further shares in cssl from time to time issued to or acquired. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 08 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 août 2005
    Livré le 08 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 08 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CORNERSTONE ACQUISITIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 janv. 2018Commencement of winding up
    09 sept. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0