TELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED

TELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 05505790
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication
    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INHOCO 3236 LIMITED03 juil. 200703 juil. 2007
    INHOCO 3236 PUBLIC LIMITED COMPANY12 juil. 200512 juil. 2005

    Quels sont les derniers comptes de TELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2018
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour TELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Confirmation of transfer of assets and liabilities
    1 pagesMISC

    Divers

    Notification from overseas registry of completion of merger
    1 pagesMISC

    Divers

    Copy of order for completion of merger
    19 pagesMISC

    Divers

    CB01 - notice of a cross border merger
    157 pagesMISC

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    26 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de Telecity Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC05

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Phillip Leo Konieczny le 01 mars 2017

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Phillip Leo Konieczny en tant qu'administrateur le 30 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Crowther en tant que directeur le 30 déc. 2016

    1 pagesTM01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 055057900013

    1 pagesMR05

    État du capital après une attribution d'actions au 09 sept. 2016

    • Capital: GBP 200,100,003
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Auth cap revoked and deleted 09/09/2016
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 15 sept. 2016

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancelllation of share premium account 14/09/2016
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2016 avec mises à jour

    28 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 01 juil. 2016

    • Capital: GBP 100,003
    3 pagesSH01

    Inscription de la charge 055057900013, créée le 23 mars 2016

    72 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Robert Andrew Coupland en tant que directeur le 14 mars 2016

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Section 1162 of ca 2006 26/02/2016
    RES13

    Qui sont les dirigeants de TELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUNTER, Anthony George
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Secrétaire
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    British66859190003
    KONIECZNY, Phillip Leo
    Amstelplein 1
    1096 Ha
    Rambrandt Tower 7th Floor
    Amsterdam
    Netherlands
    Administrateur
    Amstelplein 1
    1096 Ha
    Rambrandt Tower 7th Floor
    Amsterdam
    Netherlands
    NetherlandsAmerican204302590002
    SCHWARTZ, Eric Charles
    Amstelplein 1
    1096 Ha
    Rambrandt Tower 7th Floor
    Amsterdam
    Netherlands
    Administrateur
    Amstelplein 1
    1096 Ha
    Rambrandt Tower 7th Floor
    Amsterdam
    Netherlands
    NetherlandsAmerican204409940001
    DAVIES, Emma Suzanne
    28 Redford Drive
    Bramhall
    SK7 3PG Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    28 Redford Drive
    Bramhall
    SK7 3PG Stockport
    Cheshire
    British79319710001
    HAYMAN, Elizabeth Sara Jane
    54 Leyspring Road
    E11 3BX London
    Secrétaire
    54 Leyspring Road
    E11 3BX London
    British40541160002
    YATES, Geoffrey Edward
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    British43873560003
    YATES, Geoffrey Edward
    10 Flamingo Close
    AL10 9LU Hatfield
    Hertfordshire
    Secrétaire
    10 Flamingo Close
    AL10 9LU Hatfield
    Hertfordshire
    British106642310001
    COUPLAND, Robert Andrew
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Administrateur
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    United KingdomBritish138313750002
    CROWTHER, David
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Administrateur
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    United KingdomBritish184391050001
    HAGEMAN, Wilhelmus Theresia Jozef
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Administrateur
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    NetherlandsDutch190923150001
    MCARTHUR-MUSCROFT, Brian David
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Administrateur
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    EnglandBritish120812990001
    MORSE JR, Robert Lee
    677 Laurel Avenue
    Menlo Park
    Ca 94025
    Usa
    Administrateur
    677 Laurel Avenue
    Menlo Park
    Ca 94025
    Usa
    United StatesAmerican106953230001
    NOLAN, Ian Michael
    Brookmead House
    The Warren
    KT24 5RH East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Brookmead House
    The Warren
    KT24 5RH East Horsley
    Surrey
    British106520540001
    TOBIN, Michael
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Administrateur
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    EnglandBritish82337350003
    WADCOCK, Trevor Anthony
    89 Victoria Road
    OX2 7QG Oxford
    Administrateur
    89 Victoria Road
    OX2 7QG Oxford
    British79133200002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Telecity Group Limited
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Masters House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Masters House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom (England And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales
    Lieu d'enregistrementPeople With Significant Control
    Numéro d'enregistrement05603875
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TELECITYGROUP INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 mars 2016
    Livré le 04 avr. 2016
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Equinix, Inc.
    Transactions
    • 04 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 oct. 2016L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 30 janv. 2015
    Livré le 04 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 sept. 2013
    Livré le 14 sept. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Group debenture
    Créé le 02 nov. 2012
    Livré le 08 nov. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 08 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Group debenture
    Créé le 09 févr. 2010
    Livré le 18 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future obligor to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 18 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Group debenture
    Créé le 30 oct. 2007
    Livré le 10 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transactions
    • 10 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Group debenture
    Créé le 18 sept. 2006
    Livré le 30 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties) (in Such Capacity, the Securityagent)
    Transactions
    • 30 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage over securities
    Créé le 01 nov. 2005
    Livré le 18 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares, the crest rights, the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Saberasu Japan Investments Ii B.V (The Security Trustee)
    Transactions
    • 18 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage over securities (including those held on crest)
    Créé le 01 nov. 2005
    Livré le 14 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge the shares; the crest rights; and the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 14 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 nov. 2005
    Livré le 18 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Saberasu Japan Investments Ii B.V (As Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transactions
    • 18 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 nov. 2005
    Livré le 14 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 14 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0