PLATINUM RECOVERIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPLATINUM RECOVERIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05511441
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PLATINUM RECOVERIES LIMITED ?

    • Récupération de matériaux triés (38320) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe PLATINUM RECOVERIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit B3 Marston Gate
    Stirling Road South Marston Industrial Estate
    SN3 4DE Swindon
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PLATINUM RECOVERIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PLATINUM RECOVERIES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PLATINUM RECOVERIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2013

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 sept. 2013

    État du capital au 17 sept. 2013

    • Capital: GBP 1,933,193.21
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2012 au 30 juin 2013

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    État du capital après une attribution d'actions au 10 avr. 2012

    • Capital: GBP 1,933,193.21
    4 pagesSH01

    Nomination de Mr Ian Glyndwr Griffiths en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    13 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Rolf Stein en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sackville Secretaries Limited le 18 juil. 2011

    2 pagesCH04

    Cessation de la nomination de Paul Williams en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Charles Edmund Ives en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de * Unit B3 Marston Gate Stirling Road South Marston Industrial Estate Swindon SN3 4DE United Kingdom* le 25 août 2011

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Paul Williams en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Unit B2 Marston Gate Stirling Road South Marston Industrial Estate Swindon SN3 4DE United Kingdom* le 01 sept. 2010

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Unit a4 Marston Gate Stirling Road South Marston Industrial Estate Swindon SN3 4DE United Kingdom* le 01 sept. 2010

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de PLATINUM RECOVERIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SACKVILLE SECRETARIES LIMITED
    25 Sackville Street
    W1S 3EJ London
    Suite One Fifth Floor
    Secrétaire
    25 Sackville Street
    W1S 3EJ London
    Suite One Fifth Floor
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06256788
    122723270001
    GRIFFITHS, Ian Glyndwr
    Marston Gate
    Stirling Road South Marston Industrial Estate
    SN3 4DE Swindon
    Unit B3
    United Kingdom
    Administrateur
    Marston Gate
    Stirling Road South Marston Industrial Estate
    SN3 4DE Swindon
    Unit B3
    United Kingdom
    WalesBritish151846000001
    HILLS, Gary John
    Milton Avenue
    BA2 4QZ Bath
    27
    Bath And North East Somerset
    Administrateur
    Milton Avenue
    BA2 4QZ Bath
    27
    Bath And North East Somerset
    United KingdomBritish138668610003
    IVES, Charles Edmund
    Marston Gate
    Stirling Road South Marston Industrial Estate
    SN3 4DE Swindon
    Unit B3
    United Kingdom
    Administrateur
    Marston Gate
    Stirling Road South Marston Industrial Estate
    SN3 4DE Swindon
    Unit B3
    United Kingdom
    United KingdomBritish162601900001
    LAFFERTY, Henry
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    Administrateur
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    EnglandBritish146249130001
    MOAYEDI, Paris
    The Old House Bridge Green
    Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    The Old House Bridge Green
    Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish2646590001
    MORNINGTON SECRETARIES LIMITED
    43 Mornington Road
    E4 7DT Chingford
    London
    Secrétaire
    43 Mornington Road
    E4 7DT Chingford
    London
    87701330001
    DEEGAN, David Edward, Dr
    59 Calais Dene
    OX18 2NR Bampton
    Oxfordshire
    Administrateur
    59 Calais Dene
    OX18 2NR Bampton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish112071380002
    PUGH, David Charles
    3 Llanerchydol Park
    SY21 9QE Welshpool
    Powys
    Administrateur
    3 Llanerchydol Park
    SY21 9QE Welshpool
    Powys
    British116648440001
    RICHARDSON, Peter Miles
    43 Portland Road
    Summerton
    OX2 7EZ Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    43 Portland Road
    Summerton
    OX2 7EZ Oxford
    Oxfordshire
    Other101061800002
    STEIN, Rolf
    2 Cedarways
    GU9 8SW Farnham
    Surrey
    Administrateur
    2 Cedarways
    GU9 8SW Farnham
    Surrey
    United KingdomGerman125787810001
    WATKINS, Philip David
    58 Arthur Road
    RG41 2SY Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    58 Arthur Road
    RG41 2SY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish98187380001
    WILLIAMS, Paul
    Apley Way
    CB23 6DF Lower Cambourne
    10
    Cambs
    England
    Administrateur
    Apley Way
    CB23 6DF Lower Cambourne
    10
    Cambs
    England
    United KingdomBritish130755690001

    PLATINUM RECOVERIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of deposit
    Créé le 26 mai 2010
    Livré le 03 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 00650997 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 mai 2009
    Livré le 02 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An account charge agreement
    Créé le 14 juil. 2008
    Livré le 01 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights, title and interest in and to each of the deposits. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Europe Arab Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 09 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 21 mai 2009
    Debenture
    Créé le 14 juil. 2008
    Livré le 01 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge all investments,all equipment,all amounts standing to the credit of any account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Europe Arab Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An assignment agreement
    Créé le 14 juil. 2008
    Livré le 01 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assigned rights means all right, title, benefit and interest under the assigned contracts see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Europe Arab Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 03 avr. 2009
    • 09 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 juil. 2007
    Livré le 02 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0