GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED

GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05513232
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au05 avr. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de John Richard Allen en tant que directeur le 30 sept. 2012

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juin 2012

    État du capital au 06 juin 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 05 avr. 2011

    16 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Richard Allen le 06 juin 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Samuel Wilton Lee le 01 juin 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 05 avr. 2010

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    30 pagesMA

    Modification des statuts par voie législative

    2 pagesCC05

    Cessation de la nomination de David Povall en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de William Wilks en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles Nicholson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Bunbury en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Euan Anstruther Gough Calthorpe en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Martin Brennan Woolhouse en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Mark Lee en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Mark Samuel Wilton Lee en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 05 avr. 2009

    14 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WOOLHOUSE, Martin Brennan
    Howards Meadow
    Kings Cliffe
    PE8 6YJ Peterborough
    7
    Northamptonshire
    England
    Secrétaire
    Howards Meadow
    Kings Cliffe
    PE8 6YJ Peterborough
    7
    Northamptonshire
    England
    146450850001
    LEE, Mark Samuel Wilton
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish54866930002
    LEE, Mark Samuel Wilton
    Chadwick End Farm Oldwich Lane West
    Chadwick End
    B93 0BH Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    Chadwick End Farm Oldwich Lane West
    Chadwick End
    B93 0BH Solihull
    West Midlands
    British54866930001
    READMAN, Alison Mary
    12 Prince Rupert's Way
    WS13 7ER Lichfield
    Secrétaire
    12 Prince Rupert's Way
    WS13 7ER Lichfield
    British69382380002
    SMITH, Grace Mclean
    3 David House
    43 Station Road
    DA15 7DD Sidcup
    Kent
    Secrétaire
    3 David House
    43 Station Road
    DA15 7DD Sidcup
    Kent
    British7736120003
    ACI SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Secrétaire désigné
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027740001
    ALLEN, John Richard
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish71282600003
    ANSTRUTHER -GOUGH -CALTHORPE BT, Euan Hamilton, Sir
    Elvetham Farm House
    Home Farm Road
    RG27 8AN Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Elvetham Farm House
    Home Farm Road
    RG27 8AN Hook
    Hampshire
    UkBritish194595910001
    BUNBURY, Michael William, Sir
    Flat 3
    19 Redcliffe Square
    SW10 9LA London
    Administrateur
    Flat 3
    19 Redcliffe Square
    SW10 9LA London
    EnglandBritish70449390001
    MAHONEY, Patrick Edward
    131 Cornwall Road
    HA4 6AH Ruislip Manor
    Middlesex
    Administrateur
    131 Cornwall Road
    HA4 6AH Ruislip Manor
    Middlesex
    British1622710004
    NICHOLSON, Charles Christian, Sir
    Turners Green Farm
    Elvetham
    RG27 8BE Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Turners Green Farm
    Elvetham
    RG27 8BE Hook
    Hampshire
    EnglandBritish43226700001
    PICK, Graham John
    Hellier Drive
    Wombourne
    WV5 8AH Wolverhampton
    3
    Staffordshire
    Administrateur
    Hellier Drive
    Wombourne
    WV5 8AH Wolverhampton
    3
    Staffordshire
    EnglandBritish139309010001
    POVALL, David Edward
    St. Peters Road
    Harborne
    B17 0AU Birmingham
    45
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    St. Peters Road
    Harborne
    B17 0AU Birmingham
    45
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish111052510002
    WILKS, William Henry George
    22 Cranmer Court
    Sloane Avenue
    SW3 3HN London
    Administrateur
    22 Cranmer Court
    Sloane Avenue
    SW3 3HN London
    United KingdomBritish109579700001
    ACI DIRECTORS LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Administrateur désigné
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027730001

    GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 23 janv. 2009
    Livré le 28 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    L/H property k/a harborne court 67-69 harborne road edgbaston birmingham t/no. WM172642 and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 28 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27TH june 2002 and
    Créé le 17 sept. 2007
    Livré le 02 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 04 avr. 2006
    Livré le 20 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The l/h property k/a harborne court 67/69 harborne road edgbaston birmingham t/n WM172642. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC T/a Yorkshire Bank
    Transactions
    • 20 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 june 2002 and
    Créé le 06 janv. 2006
    Livré le 12 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/2002
    Créé le 29 nov. 2005
    Livré le 13 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0