GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05513232 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 05 avr. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Richard Allen en tant que directeur le 30 sept. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 05 avr. 2011 | 16 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Richard Allen le 06 juin 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Samuel Wilton Lee le 01 juin 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 05 avr. 2010 | 14 pages | AA | ||||||||||
D éclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 30 pages | MA | ||||||||||
Modification des statuts par voie législative | 2 pages | CC05 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Povall en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Wilks en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles Nicholson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Bunbury en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Euan Anstruther Gough Calthorpe en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Martin Brennan Woolhouse en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Lee en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Samuel Wilton Lee en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 05 avr. 2009 | 14 pages | AA | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOLHOUSE, Martin Brennan | Secrétaire | Howards Meadow Kings Cliffe PE8 6YJ Peterborough 7 Northamptonshire England | 146450850001 | |||||||
| LEE, Mark Samuel Wilton | Administrateur | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands | England | British | 54866930002 | |||||
| LEE, Mark Samuel Wilton | Secrétaire | Chadwick End Farm Oldwich Lane West Chadwick End B93 0BH Solihull West Midlands | British | 54866930001 | ||||||
| READMAN, Alison Mary | Secrétaire | 12 Prince Rupert's Way WS13 7ER Lichfield | British | 69382380002 | ||||||
| SMITH, Grace Mclean | Secrétaire | 3 David House 43 Station Road DA15 7DD Sidcup Kent | British | 7736120003 | ||||||
| ACI SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 2nd Floor 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900027740001 | |||||||
| ALLEN, John Richard | Administrateur | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands | England | British | 71282600003 | |||||
| ANSTRUTHER -GOUGH -CALTHORPE BT, Euan Hamilton, Sir | Administrateur | Elvetham Farm House Home Farm Road RG27 8AN Hook Hampshire | Uk | British | 194595910001 | |||||
| BUNBURY, Michael William, Sir | Administrateur | Flat 3 19 Redcliffe Square SW10 9LA London | England | British | 70449390001 | |||||
| MAHONEY, Patrick Edward | Administrateur | 131 Cornwall Road HA4 6AH Ruislip Manor Middlesex | British | 1622710004 | ||||||
| NICHOLSON, Charles Christian, Sir | Administrateur | Turners Green Farm Elvetham RG27 8BE Hook Hampshire | England | British | 43226700001 | |||||
| PICK, Graham John | Administrateur | Hellier Drive Wombourne WV5 8AH Wolverhampton 3 Staffordshire | England | British | 139309010001 | |||||
| POVALL, David Edward | Administrateur | St. Peters Road Harborne B17 0AU Birmingham 45 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 111052510002 | |||||
| WILKS, William Henry George | Administrateur | 22 Cranmer Court Sloane Avenue SW3 3HN London | United Kingdom | British | 109579700001 | |||||
| ACI DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | 2nd Floor 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900027730001 |
GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Créé le 23 janv. 2009 Livré le 28 janv. 2009 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions L/H property k/a harborne court 67-69 harborne road edgbaston birmingham t/no. WM172642 and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27TH june 2002 and | Créé le 17 sept. 2007 Livré le 02 oct. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 04 avr. 2006 Livré le 20 avr. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The l/h property k/a harborne court 67/69 harborne road edgbaston birmingham t/n WM172642. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 june 2002 and | Créé le 06 janv. 2006 Livré le 12 janv. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/2002 | Créé le 29 nov. 2005 Livré le 13 déc. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0