WATCHSTONE GROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWATCHSTONE GROUP PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 05542221
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WATCHSTONE GROUP PLC ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WATCHSTONE GROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    Highfield Court Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Hampshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WATCHSTONE GROUP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    QUINDELL PLC02 déc. 201302 déc. 2013
    QUINDELL PORTFOLIO PLC14 juil. 201114 juil. 2011
    MISSION CAPITAL PLC22 août 200522 août 2005

    Quels sont les derniers comptes de WATCHSTONE GROUP PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WATCHSTONE GROUP PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au23 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation07 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au23 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour WATCHSTONE GROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    État du capital au 26 juil. 2024

    • Capital: GBP 4,603,833.3
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesOC138

    Certificat de réduction de la prime d'émission

    1 pagesCERT19

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2023

    65 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de groupe modifiés jusqu'au 31 déc. 2022

    68 pagesAAMD

    Déclaration de confirmation établie le 22 août 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Cessation de la nomination de Michael Howard en tant que directeur le 30 mai 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Thomas Mcaree Young en tant que directeur le 30 mai 2023

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2022

    68 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2021

    78 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2020

    91 pagesAA

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 5

    2 pagesMR05

    Déclaration de confirmation établie le 22 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    État du capital au 28 juil. 2020

    • Capital: GBP 4,603,833.3
    3 pagesSH19

    Certificat de réduction de la prime d'émission

    1 pagesCERT19

    legacy

    1 pagesOC138

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    État du capital au 19 juin 2020

    • Capital: GBP 4,603,833.3
    3 pagesSH19

    Certificat de réduction de la prime d'émission

    1 pagesCERT19

    legacy

    1 pagesOC138

    Qui sont les dirigeants de WATCHSTONE GROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BORSON, Stefan Leon
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    198092150001
    BORSON, Stefan Leon
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishSolicitor117811010002
    ROSE, Richard Sidney
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director20113670002
    BURROW, Robert Philip
    222 Grays Inn Road
    WC1X 8XF London
    Secrétaire
    222 Grays Inn Road
    WC1X 8XF London
    British97252420005
    FARRELLY, Ian Brian
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    179435400001
    GOLDENBERG, Philip
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Toad Hall
    Surrey
    Secrétaire
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Toad Hall
    Surrey
    BritishSolicitor4374520002
    SAGE, Robert Graham
    1 Amey Drive
    KT23 4AL Great Bookham
    Surrey
    Secrétaire
    1 Amey Drive
    KT23 4AL Great Bookham
    Surrey
    British74332860001
    WALKER, Edward Ian Charles
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    189083880001
    WALKER, Edward Ian Charles
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    160536720001
    WALLACE, Susan Margaret
    76 Speer Road
    KT7 0PP Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    76 Speer Road
    KT7 0PP Thames Ditton
    Surrey
    British95024880001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Secrétaire désigné
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    BOWERS, Anthony James
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director158663800001
    BRIGHT, Robert Stewart
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishInsurance Broker145809660001
    BURROW, Robert Philip
    Brook Street
    W1K 4NJ London
    67
    Great Britain
    Administrateur
    Brook Street
    W1K 4NJ London
    67
    Great Britain
    EnglandBritishSolicitor97252420005
    CALE, Jason Charles
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director68624000005
    CIARDI, Giuseppe
    47b Chester Square
    SW1W 9EA London
    Administrateur
    47b Chester Square
    SW1W 9EA London
    United KingdomItalianCompany Director86651220001
    COOLING, Robert George
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishNon Executive Director181732480001
    CURRIE, David Scott
    21 Tower Street
    WC2H 9NS London
    Third Floor
    England
    Administrateur
    21 Tower Street
    WC2H 9NS London
    Third Floor
    England
    United KingdomBritishCompany Director167052740001
    FIELDING, Robert Martin
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director187535920001
    GOLDENBERG, Philip
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Toad Hall
    Surrey
    Administrateur
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Toad Hall
    Surrey
    EnglandBritishSolicitor4374520002
    GUTHRIE, Garth Michael
    Hyde Heath Farm
    Hyde Heath
    HP6 5RW Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hyde Heath Farm
    Hyde Heath
    HP6 5RW Amersham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director51714120001
    HOWARD, Michael, Lord
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director198092400001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    21 Tower Street
    WC2H 9NS London
    Third Floor
    England
    Administrateur
    21 Tower Street
    WC2H 9NS London
    Third Floor
    England
    United KingdomBritishCompany Director43836970002
    MILTON, Dominic Scott Mcinnis
    Titchfield Lane
    Wickham
    PO17 5PG Fareham
    Quob Park
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Titchfield Lane
    Wickham
    PO17 5PG Fareham
    Quob Park
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director136151150001
    MOORSE, Laurence
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director78291360003
    MUKERJEE, Indro Mario
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishChief Executive Officer111658220001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    18 Liddington Road
    E15 3PJ London
    Administrateur
    18 Liddington Road
    E15 3PJ London
    EnglandBritishCompany Director46176700002
    SCOTT, Stephen
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director79564910002
    SINCLAIR, Emma Claudine
    1 Dudley House
    Westmoreland Street
    W1G 8PW London
    Administrateur
    1 Dudley House
    Westmoreland Street
    W1G 8PW London
    United KingdomBritishCompany Director74888990004
    SINCLAIR, Ronald Neil
    7 Cumberland Terrace
    Regents Park
    NW1 4HS London
    Administrateur
    7 Cumberland Terrace
    Regents Park
    NW1 4HS London
    United KingdomBritishCompany Director33665100003
    TERRY, Robert Simon
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director161749250001
    THORPE, Godfrey Roger
    Shiphill House East Ship Hill
    Tatsfield
    TN16 2LB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Shiphill House East Ship Hill
    Tatsfield
    TN16 2LB Westerham
    Kent
    BritishDirector51045770001
    WILLIAMS, Mark Pritchard
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director198092340001
    YOUNG, David Thomas Mcaree
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director99780820002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Administrateur désigné
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour WATCHSTONE GROUP PLC ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    24 juil. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    WATCHSTONE GROUP PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 mars 2013
    Livré le 04 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 août 2020L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 07 oct. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 25 mars 2009
    Livré le 09 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The chargors entire right title and interest in and to the shares all rights money or property of an income nature see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 avr. 2008
    Livré le 25 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on shares
    Créé le 22 déc. 2006
    Livré le 08 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The investments being 10,000 'b' ordinary shares of us$1 each in the issued share capital of the borrower and all other stocks, shares and other securities, all dividends, interest and other money. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 08 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over shares and related rights
    Créé le 22 déc. 2006
    Livré le 03 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from athens investment holding group and/or the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over all investments,all dividends,interest and other money payable thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lehman Brothers International (Europe),as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 03 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0