APEX DEVELOPMENTS UK LIMITED

APEX DEVELOPMENTS UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAPEX DEVELOPMENTS UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05546936
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de APEX DEVELOPMENTS UK LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe APEX DEVELOPMENTS UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Victoria House
    12 Hatherley Road
    DA14 4DT Sidcup
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de APEX DEVELOPMENTS UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour APEX DEVELOPMENTS UK LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour APEX DEVELOPMENTS UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 sept. 2015

    État du capital au 28 sept. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 oct. 2014

    État du capital au 15 oct. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 sept. 2013

    État du capital au 13 sept. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Povey Little Secretaries Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Changement d'adresse du siège social de * 4 Riverview, Walnut Tree Close Guildford Surrey GU1 4UX* le 16 août 2011

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    13 pagesAA

    Nomination de Mr Stephen Michael Haines en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Sean Geraghty en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Andrew Cox en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sean Geraghty en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Andrew John Cox en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Cannings en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Cox en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de APEX DEVELOPMENTS UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GERAGHTY, Sean Andrew
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    United Kingdom
    146789870001
    HAINES, Stephen Michael
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    England
    Secrétaire
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    England
    159026420001
    POVEY LITTLE SECRETARIES LIMITED
    Hatherley Road
    DA14 4DT Sidcup
    12
    Kent
    Uk
    Secrétaire
    Hatherley Road
    DA14 4DT Sidcup
    12
    Kent
    Uk
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2978957
    78899320002
    MIDGLEY, Kai Peter
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    England
    Administrateur
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    England
    EnglandBritishBuilding Contractor52569480002
    GERAGHTY, Sean Andrew
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    United Kingdom
    146789950001
    LOWE, Paul
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    United Kingdom
    British128253910001
    MIDGLEY, Kai Peter
    7 Shoreham House
    Church Street Shoreham
    TN14 7RY Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    7 Shoreham House
    Church Street Shoreham
    TN14 7RY Sevenoaks
    Kent
    BritishBuilding Contractor52569480002
    STL SECRETARIES LTD
    Edbrooke House
    St Johns Rd
    GU21 7SE Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Edbrooke House
    St Johns Rd
    GU21 7SE Woking
    Surrey
    93209440001
    CANNINGS, Ian
    Ribblesdale
    Ashford Road Bearsted
    ME14 4NL Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Ribblesdale
    Ashford Road Bearsted
    ME14 4NL Maidstone
    Kent
    EnglandBritishDirector60079720003
    COX, Andrew John
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    United Kingdom
    Gb-EngBritishDevelopment Director72536160001
    COX, Andrew John
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    England
    Administrateur
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    England
    Gb-EngBritishDevelopment Director72536160001
    GERAGHTY, Sean Andrew
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Bexley High Street
    DA5 1JX Bexley
    The Old Mill
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomIrishFinance Director165465910001
    LANE, Richard Ernest
    13 St Michaels Close
    Bickley
    BR1 2DX Bromley
    Kent
    Administrateur
    13 St Michaels Close
    Bickley
    BR1 2DX Bromley
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant19397330001
    RAJARATNAM, Sriranganathan
    20 Riverdale Road
    DA5 1QX Bexley
    Kent
    Administrateur
    20 Riverdale Road
    DA5 1QX Bexley
    Kent
    BritishAccountant72844980001
    STL DIRECTORS LTD
    Edbrooke House
    St Johns Rd
    GU21 7SE Woking
    Surrey
    Administrateur
    Edbrooke House
    St Johns Rd
    GU21 7SE Woking
    Surrey
    93241390001

    APEX DEVELOPMENTS UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 29 avr. 2009
    Livré le 01 mai 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Wits end and eynsford house high street eynsford dartford t/no K586146 and K364392 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 14 avr. 2008
    Livré le 17 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Eynsford house high street eynsford kent.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2008
    • 05 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 janv. 2006
    Livré le 24 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 déc. 2005
    Livré le 04 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 9 vambery road, london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0